Buscador CIF Logo

Actos BORME Caja Rural De Albal Coop De Credito V

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Caja Rural De Albal Coop De Credito V

Actos BORME Caja Rural De Albal Coop De Credito V - F46043824

Tenemos registrados 40 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Caja Rural De Albal Coop De Credito V con CIF F46043824

🔙 Perfil de Caja Rural De Albal Coop De Credito V
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Caja Rural De Albal Coop De Credito V

22 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: CARBALLAS VARELA RAMON;DE CASTRO SANCHEZ IGNACIO;MELCON ARBAIZAGOITIAMANUEL;SANMARTIN MAZOY JACOBO;ESTEVEZ SORO PATRICIA AINOA;BENLLOCH FERNANDEZ CUESTA IGNACIO. Datosregistrales. T 8280, L 5571, F 172, S 8, H V 4589, I/A 78 (15.11.23).

23 de Octubre de 2023
Reelecciones. Sec.Cons.Rec: LORENZO MARTINEZ MANUEL. Mie.Cons.Rec: LORENZO MARTINEZ MANUEL;MARI MARTINEZANNA-DOLORS. Pre.Cons.Rec: MARTINEZ VILA ANTONIO. Mie.Cons.Rec: MARTINEZ VILA ANTONIO;REQUENA REQUENAANTONIO. Modificaciones estatutarias. Modificación artículo 25.. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 171, S 8, H V 4589, I/A 77(16.10.23).

04 de Octubre de 2022
Modificaciones estatutarias. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales. Modificación del artículo 6º de los estatutossociales. Modificación del artículo 47º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 170, S 8, H V 4589, I/A 76(27.09.22).

03 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Dir. General: FERRIS CHILET MIGUEL. Revocaciones. Apoderado: FERRIS CHILET MIGUEL. Apo.Manc.:FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILETMIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL. Apo.Sol.: FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL.Apo.Man.Soli: FERRIS CHILET MIGUEL. Nombramientos. Dir. General: CHILET PUCHALT MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L5571, F 168, S 8, H V 4589, I/A 75 (27.05.22).

26 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 59, S 8, H V 4589,I/A 74 (19.05.22).

26 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: ANDRES NARBON ANGEL FERNANDO. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: RAMON PORTALESGASPAR VICENTE. Reelecciones. Mie.Cons.Rec: VICIANO BONORA FRANCISCO;SENA ROMERO FRANCISCO ANDRES.Vcp.Cons.Rec: SENA ROMERO FRANCISCO ANDRES. Mie.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T8280, L 5571, F 59, S 8, H V 4589, I/A 73 (19.11.21).

20 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: RAMON VILA JUAN GABRIEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 58, S 8, H V 4589, I/A 72(13.08.21).

03 de Agosto de 2021
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 58, S 8, H V 4589, I/A 71 (26.07.21).

15 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: RAMON VILA JUAN GABRIEL;FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL;COSMEALBUIXECH VICENTE RAMON. Apo.Sol.: RAMON VILA JUAN GABRIEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A70 ( 4.12.20).

11 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MARI MARTINEZ PEDRO. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: MARI MARTINEZ ANNA-DOLORS;REQUENA REQUENA ANTONIO. Reelecciones. Mie.Cons.Rec: ANDRES NARBON ANGEL FERNANDO;MARTINEZVILA ANTONIO;LORENZO MARTINEZ MANUEL. Pre.Cons.Rec: MARTINEZ VILA ANTONIO. Sec.Cons.Rec: LORENZO MARTINEZMANUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A 69 ( 4.03.20).

05 de Julio de 2019
Nombramientos. Dir. General: FERRIS CHILET MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 55, S 8, H V 4589, I/A 67 (27.06.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: MARTI BOTELLA JULIO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A 68 (27.06.19).

09 de Agosto de 2018
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 55, S 8, H V 4589, I/A 66 ( 2.08.18).

17 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. Articulo 13 modificado. Articulo 15 modificado. Articulo 32 de los estatutos modificado. Articulo 60modificado. Otros conceptos: Rectificacion de la redacción de los articulos 13, 15, 32 y 60 de los estatutos sociales, obrantes en lainscripción 58ª de esta hoja. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 53, S 8, H V 4589, I/A 65 (10.04.18).

03 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ VILA ANTONIO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 53, S 8, H V 4589, I/A 64 (23.03.18).

11 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MARTI BOTELLA JULIO;HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Vcp.Cons.Rec: MARTI BOTELLAJULIO. Sec.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Nombramientos. Vcp.Cons.Rec: SENA ROMERO FRANCISCO ANDRES.Sec.Cons.Rec: LORENZO MARTINEZ MANUEL. Reelecciones. Mie.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA JOSE ANTONIO;SENAROMERO FRANCISCO ANDRES;VICIANO BONORA FRANCISCO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 52, S 8, H V 4589, I/A 63 (4.09.17).

25 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MUÑOZ VILA FRANCISCO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 52, S 8, H V 4589, I/A 62

10 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: VILA VILA VICENT. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 61 ( 3.05.17).

14 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: FERRIS CHILET JUAN. Nombramientos. Apo.Sol.: FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALTMIGUEL;COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 60 ( 4.11.16).

01 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN;LORENZO MARTINEZ MANUEL;MARI MARTINEZ PEDRO;MARTINEZVILA ANTONIO;MUÑOZ VILA FRANCISCO. Pre.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: ANDRESNARBON ANGEL FERNANDO;MARTINEZ VILA ANTONIO;MUÑOZ VILA FRANCISCO;LORENZO MARTINEZ MANUEL;MARIMARTINEZ PEDRO. Pre.Cons.Rec: MARTINEZ VILA ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Apartado 2 del punto 2 del art. 13modificado. Modificados los apartados 1, 2 y 3, eliminándose el apartado 5 del articulo 14.. Modificacion del apartado II. Sanciones delarticulo 15.. Art. 16 modificado. art. 17 modificado. Art. 18 modificado. Art. 19 modificado. Art. 20 modificado. modificado apartado c)articulo 25. Modificacion del apart. b) del art. 27. Modificado el apart. c) art. 32. Modificacion del parrafo 6 del art. 33. Modificacion delparraf. 2 del art. 36. modificación de los párrafoa 1º y 2º del art. 42 . se añade un nuevo párrafo 4º al art. 47. Se modifica el párrafo 5ºdel art. 60. Se modifica el apartado de Disposiciones transitorias. . Datos registrales. T 8280, L 5571, F 47, S 8, H V 4589, I/A 58(24.11.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 51, S 8,H V 4589, I/A 59 (24.11.15).

14 de Julio de 2015
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 47, S 8, H V 4589, I/A 57 ( 7.07.15).

12 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL. Apo.Sol.: FERRIS CHILET MIGUEL;CHILETPUCHALT MIGUEL;COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON;COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON. Datos registrales. T 8280, L5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 56 ( 5.02.15).

22 de Mayo de 2014
Otros conceptos: El domicilio social desde el 31 de marzo de 2.003, esta ubicado en Albal, Plaa del Jardi, nº 24, segun certificado delAyuntamiento de Albal, de 3/04/2014, por cambio de rotulacion de la calle. Datos registrales. T 3876, L 1188, F 190, S 8, H V 4589,I/A 31 M (14.05.14).

05 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA FRANCISCO;HERNANDEZ VILA JOSE ANTONIO;MARTI BOTELLAJULIO;MARTINEZ MARTINEZ MARIANO;DELHOM VILA JOSE. Pre.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN. Sec.Cons.Rec: HERNANDEZVILA FRANCISCO. Vcp.Cons.Rec: MARTI BOTELLA JULIO. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: SENA ROMERO FRANCISCOANDRES;HERNANDEZ VILA FRANCISCO;VICIANO BONORA FRANCISCO;HERNANDEZ VILA JOSE ANTONIO;MARTI BOTELLAJULIO. Pre.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN. Vcp.Cons.Rec: MARTI BOTELLA JULIO. Sec.Cons.Rec: HERNANDEZ VILAFRANCISCO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 54 (28.10.13).

Revocaciones. Apo.Manc.: HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 55(28.10.13).

21 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON;FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL.Datos registrales. T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 52 ( 9.08.12).

Revocaciones. Apoderado: ASENCIO MARI FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: ASENCIO MARI FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.:CHILET PUCHALT MIGUEL;FERRIS CHILET MIGUEL;IBORRA GARCIA AMADEO MANUEL;ASENCIO MARI FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 53 ( 9.08.12).

17 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apo.Manc.: ASENCIO MARI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 51 (7.08.12).

29 de Junio de 2012
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 50 (20.06.12).

16 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: CARBALLAS VARELA RAMON;MORENO RUMBAO FRANCISCO JAVIER;BENLLOCH FERNANDEZCUESTA IGNACIO;CARRILLO SANCHEZ JOAQUIN. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 44, S 8, H V 4589, I/A 49 ( 7.02.12).

09 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 43, S8, H V 4589, I/A 48 (28.11.11).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 42, S 8, H V 4589,I/A 47 (28.11.11).

31 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: FERRERONS DELHOM JOSE. Pre.Cons.Rec: FERRERONS DELHOM JOSE. Mie.Cons.Rec:FERRIS CHILET JUAN. Vcp.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN. Mie.Cons.Rec: MARI MARTINEZ PEDRO;MUÑOZ VILAFRANCISCO;SANCHIS FRESNEDO JOSE. Sec.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Nombramientos. Mie.Cons.Rec:FERRIS CHILET JUAN;MUÑOZ VILA FRANCISCO. Pre.Cons.Rec: FERRIS CHILET JUAN. Vcp.Cons.Rec: MARTI BOTELLA JULIO.Sec.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Mie.Cons.Rec: LORENZO MARTINEZ MANUEL;MARI MARTINEZPEDRO;MARTINEZ VILA ANTONIO. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 45 (20.10.11).

Revocaciones. Apo.Manc.: FERRERONS DELHOM JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTI BOTELLA JULIO. Datosregistrales. T 8280, L 5571, F 41, S 8, H V 4589, I/A 46 (20.10.11).

02 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: ASENSIO MARI FRANCISCO JAVIER;FERRIS CHILET MIGUEL;CHILET PUCHALT MIGUEL. Datosregistrales. T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 44 (21.10.10).

09 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: CHILET PUCHALT MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 43(29.07.10).

26 de Octubre de 2009
Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 42

30 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: FABRA CHIRIVELLA ANTONIO JAVIER. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: HERNANDEZ VILAJOSE ANTONIO. Reelecciones. Mie.Cons.Rec: DELHOM VILA JOSE;HERNANDEZ VILA FRANCISCO;MARTI BOTELLAJULIO;MARTINEZ MARTINEZ MARIANO;MARI MARTINEZ PEDRO. Sec.Cons.Rec: HERNANDEZ VILA FRANCISCO. Datosregistrales. T 8280, L 5571, F 39, S 8, H V 4589, I/A 41 (21.09.09).

12 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: ASENCIO MARI FRANCISCO JAVIER;FERRIS CHILET MIGUEL. Datos registrales. T 8280, L 5571,F 39, S 8, H V 4589, I/A 40 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información