Buscador CIF Logo

Actos BORME Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha

Actos BORME Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha - F02004182

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha con CIF F02004182

🔙 Perfil de Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Caja Rural De Casas Ibañez Sociedad Cooperativa De Credito De Castilla-la Mancha

23 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES. Consejero: ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES;EVAMARIA MURCIA GOMEZ;GARCIA MONTEAGUDO CONSTANTINO;FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL MARIANO. Nombramientos.Consejero: EVA MARIA MURCIA GOMEZ;MEDINA PEÑARRUBIA EVA MARIA;HONRUBIA MUÑOZ CARMEN;FERNANDEZ GOMEZMIGUEL MARIANO. Presidente: EVA MARIA MURCIA GOMEZ. Datos registrales. T 1035, L 799, F 144, S 8, H AB 5792, I/A 54(16.10.23).

06 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONIAL. Datos registrales. T 1035, L 799, F 143,S 8, H AB 5792, I/A 52 (30.08.23).

Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1035, L 799, F 143,S 8, H AB 5792, I/A 53 (30.08.23).

10 de Agosto de 2021
Reelecciones. Vicepresid.: MOYA DEFEZ MARIO. Consejero: MOYA DEFEZ MARIO. Secretario: CUENCA NIETO VIRGILIO.Consejero: CUENCA NIETO VIRGILIO;GOMEZ SANCHEZ PASCUAL FERNANDO;JIMENEZ GOMEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SANZGREGORIO. Datos registrales. T 977, L 741, F 201, S 8, H AB 5792, I/A 50 ( 3.08.21).

15 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVALON GARCIA LUIS. Presidente: NOHALES MARTINEZ PAULINO. Consejero: NOHALESMARTINEZ PAULINO. Nombramientos. Consejero: EVA MARIA MURCIA GOMEZ;FERNANDEZ GOMEZ MIGUEL MARIANO.Presidente: ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES. Reelecciones. Consejero: ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES;GARCIAMONTEAGUDO CONSTANTINO. Datos registrales. T 977, L 741, F 201, S 8, H AB 5792, I/A 48 ( 6.11.19).

30 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONIAL. Datos registrales. T 977, L 741, F 201, S8, H AB 5792, I/A 47 (23.09.19).

08 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Consejero: MOYA DEFEZ MARIO. Vicepresid.: MOYA DEFEZ MARIO. Consejero: CUENCA NIETOVIRGILIO;JIMENEZ GOMEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SANZ GREGORIO. Secretario: CUENCA NIETO VIRGILIO. Consejero: GOMEZSANCHEZ PASCUAL FERNANDO. Datos registrales. T 977, L 741, F 200, S 8, H AB 5792, I/A 45 (31.08.17).

22 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: MUÑOZ PEREZ GABRIEL. Apo.Man.Soli: PEREZ TAMAYO JOSE MARIA;NIETO GOMEZALBERTO;PEREZ ALARCON DEOGRACIAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ TAMAYO JOSE MARIA;NIETO GOMEZALBERTO;SANZ LOPEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 976, L 740, F 132, S 8, H AB 5792, I/A 44 (15.12.16).

08 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PICO GONZALEZ FRANCISCO DANIEL. Secretario: PICO GONZALEZ FRANCISCO DANIEL.Nombramientos. Secretario: CUENCA NIETO VIRGILIO. Consejero: GOMEZ SANCHEZ PASCUAL FERNANDO. Datos registrales.T 944, L 708, F 84, S 8, H AB 5792, I/A 42 (31.10.16).

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONIAL. Datos registrales. T 976, L 740, F 132,S 8, H AB 5792, I/A 43 (31.10.16).

18 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ TAMAYO JOSE MARIA;NIETO GOMEZ ALBERTO. Datos registrales. T 944, L 708, F 84, S 8,H AB 5792, I/A 41 ( 9.11.15).

22 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Consejero: NOHALES MARTINEZ PAULINO. Presidente: NOHALES MARTINEZ PAULINO. Consejero: GARCIAMONTEAGUDO CONSTANTINO;ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES;NAVALON GARCIA LUIS. Datos registrales. T 944, L 708, F84, S 8, H AB 5792, I/A 40 (15.09.15).

30 de Mayo de 2014
Otros conceptos: Adaptación de Estatutos a la Ley 11/2010 de 4 de Noviembre de Cooperativas y modificacion de la totalidad de losarticulos de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 936, L 700, F 128, S 8, H AB 5792, I/A 39 (23.05.14).

17 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: TOLOSA GOMEZ MIGUEL;CABEZAS JIMENEZ RAMONA. Secretario: CABEZAS JIMENEZRAMONA. Consejero: PICO GONZALEZ FRANCISCO DANIEL. Nombramientos. Consejero: PICO GONZALEZ FRANCISCODANIEL. Secretario: PICO GONZALEZ FRANCISCO DANIEL. Consejero: JIMENEZ GOMEZ JUAN ANTONIO;LOPEZ SANZGREGORIO. Reelecciones. Consejero: MOYA DEFEZ MARIO. Vicepresid.: MOYA DEFEZ MARIO. Consejero: CUENCA NIETOVIRGILIO. Datos registrales. T 910, L 674, F 31, S 8, H AB 5792, I/A 37 (10.10.13).

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES VLC SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 910, L 674, F 31, S 8, H AB 5792,I/A 38 (10.10.13).

19 de Julio de 2012
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 910, L 674, F 31, S 8, HAB 5792, I/A 36 (10.07.12).

29 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 910, L 674, F 31, S 8, HAB 5792, I/A 35 (18.11.11).

20 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO PEREZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: NAVALON GARCIA LUIS.Reelecciones. Consejero: NOHALES MARTINEZ PAULINO. Presidente: NOHALES MARTINEZ PAULINO. Consejero: GARCIAMONTEAGUDO CONSTANTINO;ZAFRA CLARAMUNT JOSE ANDRES. Datos registrales. T 894, L 658, F 154, S 8, H AB 5792, I/A34 (12.09.11).

23 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 894, L 658, F 154, S 8, HAB 5792, I/A 32 (12.08.10).

Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 894, L 658, F 154, S 8, HAB 5792, I/A 33 (12.08.10).

16 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ TAMAYO JOSE MARIA;NIETO GOMEZ ALBERTO. Datos registrales. T 877, L 641, F 58, S 8,H AB 5792, I/A 31 ( 7.04.10).

21 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL VALIENTE JOSE. Nombramientos. Consejero: PICO GONZALEZ FRANCISCO DANIEL.Reelecciones. Consejero: MOYA DEFEZ MARIO. Vicepresid.: MOYA DEFEZ MARIO. Consejero: CUENCA NIETOVIRGILIO;TOLOSA GOMEZ MIGUEL;CABEZAS JIMENEZ RAMONA. Secretario: CABEZAS JIMENEZ RAMONA. Datos registrales.T 877, L 641, F 58, S 8, H AB 5792, I/A 30 (10.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información