Buscador CIF Logo

Actos BORME Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha

Actos BORME Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha - F02004299

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Albacete para Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha con CIF F02004299

馃敊 Perfil de Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Albacete

Actos BORME de Caja Rural De Villamalea Sociedad Cooperativa De Credito Agrario De Castilla La Mancha

19 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN. Consejero: RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN. Vicepresid.:JIMENEZ GARCIA CARMEN. Consejero: JIMENEZ GARCIA CARMEN;GARCIA ESCRIBANO RAFAEL;PARRE脩O ESCRIBANOMONTSERRAT. Nombramientos. Consejero: RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN;JIMENEZ GARCIA CARMEN;ESCRIBANOSOTOS FRANCISCO;SAEZ CUTANDA MARIA JOSEFA;PARRE脩O DESCALZO BLADIMIRO. Consj. Supl.: PARRE脩O ESCRIBANOMONTSERRAT;MOTILLA OLMEDA ANA MARIA. Presidente: RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN. Vicepresid.: JIMENEZ GARCIACARMEN. Datos registrales. T 1020, L 784, F 74, S 8, H AB 6129, I/A 52 (10.10.23).

17 de Julio de 2023
Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 1020, L 784, F 73, S8, H AB 6129, I/A 51 (11.07.23).

02 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ ALARCON SUSANA. Apoderado: CAMPOS ORTIZ JUAN FELIPE. Datos registrales. T1020, L 784, F 73, S 8, H AB 6129, I/A 50 (24.11.22).

04 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: LARREY RUBIO JUAN TOMAS. Consejero: LARREY RUBIO JUAN TOMAS;HUERTA CUENCAJOSE. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ GARCIA CARMEN;SAEZ CUTANDA MARIA JOSEFA. Consj. Supl.: TELLEZSORIANO GUSTAVO;CARRASCO VALERO VICENTE. Vicepresid.: JIMENEZ GARCIA CARMEN. Datos registrales. T 1020, L 784,F 72, S 8, H AB 6129, I/A 49 (27.10.22).

18 de Agosto de 2021
Reelecciones. Secretario: LOPEZ GARRIDO FRANCISCO JAVIER. Consejero: PARRE脩O HERRERO FELIX;MONTERO ANGUIXMARIA;MURCIA PARDO MARIA PILAR. Datos registrales. T 1020, L 784, F 72, S 8, H AB 6129, I/A 47 (10.08.21).

11 de Agosto de 2020
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 984, L 748, F 121,S 8, H AB 6129, I/A 46 ( 4.08.20).

14 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: TELLEZ PARDO ANTONIO. Presidente: TELLEZ PARDO ANTONIO. Nombramientos. Consejero:RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN. Presidente: RAMOS FERNANDEZ ANA BELEN. Reelecciones. Vicepresid.: LARREY RUBIOJUAN TOMAS. Consejero: LARREY RUBIO JUAN TOMAS;GARCIA ESCRIBANO RAFAEL;HUERTA CUENCA JOSE;PARRE脩OESCRIBANO MONTSERRAT. Datos registrales. T 984, L 748, F 121, S 8, H AB 6129, I/A 45 ( 7.01.20).

24 de Julio de 2017
Nombramientos. Consj. Supl.: ANGUIX IBA脩EZ FIDEL;LOZANO DESCALZO JUAN. Reelecciones. Secretario: LOPEZ GARRIDOFRANCISCO JAVIER. Consejero: PARRE脩O HERRERO FELIX;MONTERO ANGUIX MARIA;MURCIA PARDO MARIA PILAR. Datosregistrales. T 984, L 748, F 121, S 8, H AB 6129, I/A 43 (17.07.17).

28 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NOGUERON MARTINEZ JAVIER ENRIQUE. Datos registrales. T 973, L 737, F 136, S 8, H AB 6129,I/A 41 (21.06.17).

Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONIAL. Datos registrales. T 973, L 737, F 136,S 8, H AB 6129, I/A 42 (21.06.17).

14 de Julio de 2016
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 47.- COMPOSICION DEL CONSEJO RECTOR Y CAPACIDAD PARA SER MIEMBRO DELMISMO. 1.- El Consejo Rector, se compondr谩 de nueve miembros titulares: Presidente, Vicepresidente, Secretario y seis vocalesnumerados correlativamente del uno al seis, que ser谩n elegidos, de entre los socios, por la ARTICULO 48.- FORMA DE ELECCIONDE LOS CONSEJEROS POR LA ASAMBLEA GENERAL. En las elecciones para acceder al Consejo Rector, la presentaci贸n decandidaturas ser谩 por el sistema de listas abiertas. Podr谩n proponer candidatos para la elecci贸n o renovaci贸n de Consejeros, tanto elConsejo Rector ARTICULO 49.- DURACION Y CESE DE CARGOS EN EL CONSEJO RECTOR. Los miembros del Consejo Rectorser谩n elegidos por un per铆odo de cuatro a帽os, a partir de su elecci贸n, que se perfeccionar谩 con su inscripci贸n en el Registro de AltosCargos del Banco de Espa帽a y en su hom贸nimo de la Junta de. Datos registrales. T 942, L 706, F 29, S 8, H AB 6129, I/A 38 (7.07.16).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ANGUIX IBA脩EZ FIDEL;LOZANO DESCALZO JUAN. Datos registrales. T 973, L 737, F 136, S 8, HAB 6129, I/A 39 ( 7.07.16).

22 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARCIA EDUARDO. Datos registrales. T 942, L 706, F 29, S 8, H AB 6129, I/A 37(15.12.15).

04 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: NOGUERON MARTINEZ JAVIER ENRIQUE;CAMPOS ORTIZ JUAN FELIPE. Datos registrales. T942, L 706, F 28, S 8, H AB 6129, I/A 36 (27.10.15).

21 de Julio de 2015
Reelecciones. Consejero: TELLEZ PARDO ANTONIO. Presidente: TELLEZ PARDO ANTONIO. Consejero: LARREY RUBIO JUANTOMAS. Vicepresid.: LARREY RUBIO JUAN TOMAS. Consejero: GARCIA ESCRIBANO RAFAEL;HUERTA CUENCAJOSE;PARRE脩O ESCRIBANO MONTSERRAT;LOZANO DESCALZO JUAN. Datos registrales. T 942, L 706, F 28, S 8, H AB 6129,I/A 35 (14.07.15).

24 de Marzo de 2014
Otros conceptos: Modificaci贸n de Estatutos para su adaptaci贸n a la Ley 11/2010 de 4 de Noviembre de Cooperativas de Castilla-LaMancha. Datos registrales. T 937, L 701, F 6, S 8, H AB 6129, I/A 34 (17.03.14).

30 de Octubre de 2013
Revocaciones. Auditor: GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 909, L 673, F 2, S 8, HAB 6129, I/A 32 (23.10.13).

11 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Secretario: LOPEZ GARRIDO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ANGUIX IBA脩EZ FIDEL;GONZALEZ GARCIAEDUARDO;PARRE脩O HERRERO FELIX;MONTERO ANGUIX MARIA;MURCIA PARDO MARIA PILAR. Datos registrales. T 909, L673, F 2, S 8, H AB 6129, I/A 31 ( 4.09.13).

01 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS ORTIZ RODRIGO. Nombramientos. Consejero: LOZANO DESCALZO JUAN.

Reelecciones. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 909, L 673, F 2, S 8, H AB6129, I/A 30 (19.07.11).

27 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: NOGUERON MARTINEZ JAVIER ENRIQUE;CAMPOS ORTIZ JUAN FELIPE. Datos registrales. T880, L 644, F 132, S 8, H AB 6129, I/A 28 (16.04.10).

23 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARCIA EDUARDO;HONRUBIA PEREZ NICASIO. Secretario: LOPEZ GARRIDOFRANCISCO JAVIER. Consejero: MURCIA PARDO MARIA PILAR;MONTERO ANGUIX MARIA;ANGUIX IBA脩EZ FIDEL.Nombramientos. Secretario: LOPEZ GARRIDO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ANGUIX IBA脩EZ FIDEL;GONZALEZ GARCIAEDUARDO;PARRE脩O HERRERO FELIX;MONTERO ANGUIX MARIA;MURCIA PARDO MARIA PILAR. Datos registrales. T 880, L644, F 132, S 8, H AB 6129, I/A 27 (14.07.09).

03 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOGUERON MARTINEZ JAVIER ENRIQUE;CAMPOS ORTIZ JUAN FELIPE;GONZALEZ ALARCONSUSANA. Datos registrales. T 844, L 608, F 125, S 8, H AB 6129, I/A 26 (23.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n