Actos BORME de Caja Rural San Jose De Burriana Coop. De Credito V
03 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Sec.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Mie.Cons.Rec:FERRER FECED CANDIDO;MALO ROCHERA CRISTIAN ALEJANDRO;PIQUERES RECATALA JUAN JOSE;FANDOS GOZALBOBLAS;IZQUIERDO BURDEUS MIGUEL. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Sec.Cons.Rec: PEREZPERIS JUAN AGUSTIN. Mie.Cons.Rec: CANDIDO-ANTONIO FERRER FECED;MALO ROCHERA CRISTIANALEJANDRO;PIQUERES RECATALA JUAN JOSE;FANDOS GOZALBO BLAS. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 70, S 8, H CS1967, I/A 106 (27.07.18).
11 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 69, S 8, H CS1967, I/A 105 ( 4.07.18).
07 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CHIVA CARBONELL GLORIA. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 68, S 8, H CS 1967, I/A 103(20.04.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: SEBASTIA LOPEZ MARIA PILAR. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 68, S 8, H CS 1967, I/A 104(20.04.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: VILALLONGA ENRIQUE MARIA AMPARO. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 68, S 8, H CS 1967, I/A102 ( 8.02.18).
21 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: UBEDA PEREZ FRANCISCO JAVIER;PERELLO GUAL JOAN. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 67,
20 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: FONT DE MORA SAINZ PABLO. Datos registrales. T 1741, L 1302, F 67, S 8, H CS 1967, I/A 100(27.11.17).
07 de Noviembre de 2017Modificaciones estatutarias. modificaci贸n articulo 6. modificacion articulo 32. modificacion articulo 41. Otros conceptos: Inclusi贸nDisposici贸n transitoria Primera. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 169, S 8, H CS 1967, I/A 99 (25.10.17).
03 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: SANAHUJA SANAHUJA MARTA. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 168, S 8, H CS 1967, I/A97 (26.07.17).
20 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 168, S 8, H CS1967, I/A 95 ( 6.07.17).
Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: GARCIA MONSONIS RAMON JOSE. Suplente: SANAHUJA SANAHUJA MARTA.Nombramientos. Mie.Cons.Rec: SANAHUJA SANAHUJA MARTA. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 168, S 8, H CS 1967, I/A 96( 6.07.17).
19 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: FERRER BLANCO ISABEL. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 166, S 8, H CS 1967, I/A 94(11.01.17).
18 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: FENOLLOSA ESTEVE MARIA. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 164, S 8, H CS 1967, I/A 91(10.01.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUEROLA FERRER FRANCISCA. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 165, S 8, H CS 1967, I/A 92(10.01.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO ALAMAN PERFECTO MANUEL. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 165, S 8, H CS 1967,I/A 93 (10.01.17).
05 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: AYMERICH ROS DOMINGO. Apo.Sol.: CANTAVELLA VICENT JOSE. Apoderado: ESCRIBA MU脩OZJUAN CARLOS. Apo.Manc.: ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS. Apo.Man.Soli:ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS. Apoderado: FORTU脩O CENTELLES SALVADOR VICENTE. Apo.Manc.: LOPEZ CAMALLONGAMIGUEL. Apoderado: LOPEZ CAMALLONGA MIGUEL;LOPEZ CAMALLONGA MIGUEL. Apo.Manc.: LOPEZ CAMALLONGA MIGUEL.Apoderado: LOPEZ CAMALLONGA MIGUEL;MELCHOR IZQUIERDO MATILDE;MONFORT ENRIQUE DAVID;MONFORT ENRIQUEDAVID;SAFONT MARTINEZ ENRIQUE. Apo.Manc.: SANCHIS URIOS JAIME. Apoderado: SANCHIS URIOS JAIME. Apo.Manc.:SANCHIS URIOS JAIME. Apoderado: SANCHIS URIOS JAIME. Apo.Manc.: TRAVER MONFORT JOSE LUIS. Apo.Sol.: TRAVERMONFORT JOSE LUIS. Apoderado: TRAVER MONFORT JOSE LUIS. Apo.Manc.: TRAVER MONFORT JOSE LUIS. Apo.Sol.: VELEZPEREZ JUAN;BALAGUER ESCRIG CONRADO. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 163, S 8, H CS 1967, I/A 89 (23.11.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL;ROSELLO FRIAS VICTORIANO;ROS BERRUEZOMARIA DEL CARMEN;MORENO GARCIA ANA BELEN;RODRIGUEZ MIRAS MARIA LUISA. Datos registrales. T 1684, L 1245, F163, S 8, H CS 1967, I/A 90 (23.11.16).
06 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ DE ASIS MARIA DOLORES. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 163, S 8, H CS 1967, I/A88 (28.09.16).
06 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: SALAS GARGALLO EDUARDO;RENAU MONFORT MARIA TERESA GEMA;GARCIAMONSONIS RAMON JOSE;IZQUIERDO BURDEUS MIGUEL;PATUEL NAVARRO ALEJANDRO;HERRERA CHABRERAJAIME;SAFONT MU脩OZ JORGE. Pre.Cons.Rec: SALAS GARGALLO EDUARDO. Vcp.Cons.Rec: HERRERA CHABRERA JAIME.Mie.Cons.Rec: PATUEL NAVARRO ALEJANDRO. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: SALAS GARGALLO EDUARDO;IZQUIERDO
26 de Julio de 2016Revocaciones. Dir. General: ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 162, S 8, H CS 1967, I/A 86 (8.07.16).
13 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: RAMOS CODINA RUTH. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 162, S 8, H CS 1967, I/A 85 ( 6.07.16).
12 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 162, S 8, H CS 1967, I/A 84 ( 5.07.16).
30 de Marzo de 2016Otros conceptos: Hacer constar la una duplicidad del articulo 61 ya que resulta an谩logo al articulo 62, por lo que se procede areenumerar el art铆culo, y en consecuencia el articulo 63 pasa a ser ahora el 62 y 煤ltimo, antes de la disposici贸n Adicional primera.Datos registrales. T 1684, L 1245, F 161, S 8, H CS 1967, I/A 83 (21.03.16).
13 de Enero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS;ROMERO ALAMAN PERFECTO MANUEL;GUEROLA FERRERFRANCISCA Datos registrales. T 1684, L 1245, F 161, S 8, H CS 1967, I/A 82 ( 5.01.16).
18 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: SALAS GARGALLO EDUARDO. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 159, S 8, H CS 1967, I/A 79(11.12.15).
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1684, L 1245, F 160, S 8, H CS 1967, I/A 80 (11.12.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PARELLADA DURAN ANTONIO;ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS;QUEREDA DEL AGUILARAFAEL;PISA LALANA ANGEL;PERELLO GUAL JOAN;LOSTAO BOYA JUAN;URRUTIA GONZALEZ JUAN JOSE;MARTINMAQUEDA JULIAN;BOSCH MARTI ANA MARIA;GRACIA DONNAY JAVIER;MARTINEZ GRANADOS JOSEANTONIO;CARRASCOSA FERRER MARIA AMPARO;BRUNORI IBA脩EZ RAFFAELLO TOMASSO;VILA OLTRA JOSEMANUEL;CARRASCO ACEDO FRANCISCO JOSE;GONZALEZ SANCHEZ JAVIER;ARANEGA MARTINEZ JOSEENRIQUE;POVEDA ESCRIVA CARLOS;DE LA ROSA DIAZ ISABEL MARIA;ALONSO RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL;ROSELLOFRIAS VICTORIANO;VANACLOIG PEDROS INMACULADA;GARCIA CARPIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1684, L 1245,F 160, S 8, H CS 1967, I/A 81 (11.12.15).
23 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Pre.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Sec.Cons.Rec:SALAS GARGALLO EDUARDO. Vcs.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Suplente: PATUEL NAVARRO ALEJANDRO.Revocaciones. Apoderado: MONTOLIU AYMERICH JOSE;MONTOLIU AYMERICH JOSE;MONTOLIU AYMERICH JOSE.Nombramientos. Pre.Cons.Rec: SALAS GARGALLO EDUARDO. Sec.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Vcs.Cons.Rec:PATUEL NAVARRO ALEJANDRO. Mie.Cons.Rec: IZQUIERDO BURDEUS MIGUEL. Otros conceptos: Refundici贸n de los EstatutosSociales. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 194, S 8, H CS 1967, I/A 78 (17.09.15).
19 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: PARRA RIBES LUIS. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 190, S 8, H CS 1967, I/A 72 ( 8.08.14).
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO VENTURA ALFONSO. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 190, S 8, H CS 1967, I/A 73 (8.08.14).
Nombramientos. Apoderado: USO ENRIQUE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 191, S 8, H CS 1967, I/A74 ( 8.08.14).
Nombramientos. Apoderado: RAMOS CODINA RUTH. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 191, S 8, H CS 1967, I/A 75 ( 8.08.14).
Nombramientos. Dir. General: ESCRIBA MU脩OZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 191, S 8, H CS 1967, I/A 76( 8.08.14).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: TRAVER MONFORT JOSE LUIS. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 194, S 8, H CS 1967, I/A 77( 8.08.14).
14 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE;PIQUERES RECATALA JUAN JOSE;FANDOS GOZALBO BLAS.Suplente: MALO ROCHERA CRISTIAN ALEJANDRO;MONFORT DONOSO RAMON. Mie.Cons.Rec: GAYA DIAGO MARIAJOSEFA;PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN;FERRER FECED CANDIDO. Pre.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Tes.C.Rec:PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Vcs.Cons.Rec: PEREZ PERISJUAN AGUSTIN. Mie.Cons.Rec: MALO ROCHERA CRISTIAN ALEJANDRO;FERRER FECED CANDIDO;PIQUERES RECATALAJUAN JOSE;MONTOLIU AYMERICH JOSE;FANDOS GOZALBO BLAS. Suplente: IZQUIERDO BURDEUS MIGUEL;MONFORTDONOSO RAMON. Pre.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Datos registrales. T 1637, L 1199, F 78, S 8, H CS 1967, I/A 70 (6.08.14).
Otros conceptos: modificaci贸n de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las observaciones realizadas por el Registro deCooperativas de la Comunitat Valenciana, en relaci贸n al Cap铆tulo correspondiente al Grupo cooperativa Cajas Rurales unidas y de laEntidad Cabecera y posteriormente al Grupo Cooperativo Cajamar. Datos registrales. T 1653, L 1215, F 188, S 8, H CS 1967, I/A 71( 6.08.14).
27 de Junio de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1637, L 1199, F 78, S 8, H CS1967, I/A 69 (19.06.14).
23 de Enero de 2014Otros conceptos: Modificados los Estatutos Sociales con la finalidad de establecer un texto homeg茅neo para todas las Cajas Ruralesdel Grupo Cooperativo consolidable de entidades de cr茅dito, Cajas Rurales Unidas, Cajamar, distntas de la entidad cabecera. Datosregistrales. T 1383, L 946, F 94, S 8, H CS 1967, I/A 68 (16.01.14).
29 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: ESTELLES SALES CESAR ANTONIO. Datos registrales. T 1380, L 943, F 91, S 8, H CS 1967, I/A 66(19.08.13).
26 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: CABEDO GIL JOSE ANTONIO;HUGUET ZARAGOZA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1380, L943, F 91, S 8, H CS 1967, I/A 64 (19.08.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: SEBASTIA LOPEZ MARIA PILAR. Datos registrales. T 1380, L 943, F 91, S 8, H CS 1967, I/A 65(19.08.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: CHIVA CARBONELL GLORIA. Datos registrales. T 1383, L 946, F 94, S 8, H CS 1967, I/A 67(19.08.13).
08 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 1380, L 943, F 91, S 8, H CS 1967, I/A 63 ( 2.07.13).
10 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: RENAU MONFORT MARIA TERESA GEMA;GARCIA MONSONIS RAMON JOSE;PATUELNAVARRO ALEJANDRO. Suplente: MONFORT DONOSO RAMON. Vcp.Cons.Rec: HERRERA CHABRERA JAIME. Sec.Cons.Rec:SALAS GARGALLO EDUARDO. Mie.Cons.Rec: SAFONT MU脩OZ JORGE. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: SALAS GARGALLOEDUARDO. Sec.Cons.Rec: SALAS GARGALLO EDUARDO. Mie.Cons.Rec: HERRERA CHABRERA JAIME. Vcp.Cons.Rec:HERRERA CHABRERA JAIME. Mie.Cons.Rec: SAFONT MU脩OZ JORGE;RENAU MONFORT MARIA TERESA GEMA;GARCIAMONSONIS RAMON JOSE;PATUEL NAVARRO ALEJANDRO. Suplente: MALO ROCHERA CRISTIAN ALEJANDRO;MONFORTDONOSO RAMON. Datos registrales. T 1318, L 881, F 104, S 8, H CS 1967, I/A 61 (28.12.12).
Modificaciones estatutarias. modificaci贸n articulo 59..modificacion articulo 60.modificacion articulo 61. Otros conceptos:Supresi贸n articulo 62. Fondo Central de Intercooperacion. Inclusi贸n disposicion adicional con Contrato Regulador del GrupoCooperativo Cajas Rurales. Y renumeracion estatutos. Datos registrales. T 1318, L 881, F 105, S 8, H CS 1967, I/A 62 (28.12.12).
01 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: MELCHOR IZQUIERDO MATILDE. Datos registrales. T 1318, L 881, F 104, S 8, H CS 1967, I/A 60(22.05.12).
25 de Octubre de 2011Modificaciones estatutarias. modificacion articulo 14. Datos registrales. T 1318, L 881, F 104, S 8, H CS 1967, I/A 59 (17.10.11).
19 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: NINOT ARAGO VICENTE. Suplente: SAFONT MU脩OZ JORGE. Nombramientos.Mie.Cons.Rec: SAFONT MU脩OZ JORGE. Datos registrales. T 1318, L 881, F 104, S 8, H CS 1967, I/A 58 (10.05.11).
24 de Febrero de 2011Modificaciones estatutarias. inclusion articulo 59.inclusi贸n articulo 60.inclusion articulo 61.inclusion articulo 62. Otros conceptos:Renumeraci贸n de los capitulos y articulos inmediatos siguientes a los art铆culos que se incorporan. Datos registrales. T 1318, L 881, F103, S 8, H CS 1967, I/A 57 (14.02.11).
10 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Mie.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Pre.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Mie.Cons.Rec:PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Tes.C.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Mie.Cons.Rec: FERRER FECED CANDIDO;GAYADIAGO MARIA JOSEFA;PIQUERES RECATALA JUAN JOSE;FANDOS GOZALBO BLAS. Miem.Co.Rec: DOMENECH ROCAVICENTE;FONT BLANCH JOSE;BOIRA MELCHOR VICENTE. Nombramientos. Mie.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE.Pre.Cons.Rec: MONTOLIU AYMERICH JOSE. Mie.Cons.Rec: PEREZ PERIS JUAN AGUSTIN. Tes.C.Rec: PEREZ PERIS JUANAGUSTIN. Mie.Cons.Rec: FERRER FECED CANDIDO;GAYA DIAGO MARIA JOSEFA;PIQUERES RECATALA JUAN JOSE;FANDOSGOZALBO BLAS. Miem.Co.Rec: DOMENECH ROCA VICENTE;FONT BLANCH JOSE;BOIRA MELCHOR VICENTE. Datosregistrales. T 1318, L 881, F 103, S 8, H CS 1967, I/A 56 ( 2.08.10).
20 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 1318, L 881, F 103, S 8, H CS 1967, I/A 55 ( 9.07.10).
13 de Noviembre de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.202.480,80 Euros. Resultante Suscrito: 300.019,20 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: Modificado el Art铆culo 14潞 de los estatutos sociales, por Reducci贸n de Capital Social.. Datos registrales. T1318, L 881, F 102, S 8, H CS 1967, I/A 54 ( 2.11.09).
07 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1318, L 881, F 102, S 8,H CS 1967, I/A 53 (27.07.09).