Actos BORME de Cal Gov Sa
28 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABAÑERO MORALES CARLOS. Datos registrales. T 6191 , F 134, S 8, H SE 16067, I/A 78(20.09.23).
05 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: SANCHEZ ALFARO GEMMA. Nombramientos. VsecrNoConsj: FANEGO CASTAÑON JAIME.Datos registrales. T 6191 , F 134, S 8, H SE 16067, I/A 77 (28.08.23).
27 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6191 , F 133, S 8, H SE 16067, I/A 76 (20.10.22).
28 de Abril de 2022Reelecciones. Vicepresid.: MEESSEN FREDERIC. Consejero: MEESSEN FREDERIC. Datos registrales. T 6191 , F 133, S 8, H SE16067, I/A 75 (21.04.22).
16 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6191 , F 133, S 8, H SE 16067, I/A 74 ( 7.12.21).
02 de Junio de 2021Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6191 , F 132, S 8, H SE 16067, I/A 73 (24.05.21).
29 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: DE MOT LUDWIG. Presidente: DE MOT LUDWIG. Nombramientos. Consejero: DE VICQ CEDRIC.Presidente: DE VICQ CEDRIC. Datos registrales. T 6191 , F 132, S 8, H SE 16067, I/A 72 (23.10.19).
04 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GOGORZA BERASATEGUI CRISTINA. Datos registrales. T 6191 , F 132, S 8, H SE 16067, I/A 71(25.02.19).
25 de Enero de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE SURVILLE LOIC. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GOYTRE JUAN;DOMINGUEZBORGES JUAN. Apo.Man.Soli: CHANTECLAIR JACQUES. Datos registrales. T 6191 , F 132, S 8, H SE 16067, I/A 70 (17.01.19).
13 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SURVILLE LOIC. Nombramientos. Consejero: CHANTECLAIR JACQUES. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 23º.- RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.- . Datos registrales. T 6191 , F 130, S 8, H SE 16067,I/A 68 ( 3.12.18).
13 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: IZAL SULTAN OLIVIER. Nombramientos. VsecrNoConsj: SANCHEZ ALFARO GEMMA. Datosregistrales. T 6191 , F 130, S 8, H SE 16067, I/A 67 ( 5.09.18).
04 de Mayo de 2018Nombramientos. Vicepresid.: MEESSEN FREDERIC. Reelecciones. Consejero: DE SURVILLE LOIC. Presidente: DE MOTLUDWIG. Datos registrales. T 6191 , F 130, S 8, H SE 16067, I/A 66 (23.04.18).
13 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6191 , F 129, S 8, H SE 16067, I/A 65 ( 4.09.17).
29 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LUGOL BERTRAND;BALTHAZARD GABRIEL. Nombramientos. Consejero: DE SURVILLE LOOC.Datos registrales. T 6191 , F 127, S 8, H SE 16067, I/A 61 (18.05.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LUGOL BERTRAND. Datos registrales. T 6191 , F 128, S 8, H SE 16067, I/A 62 (18.05.17).
Revocaciones. Apoderado: EUGUI RODRIGUEZ IGNACIO;EUGUI RODRIGUEZ IGNACIO;EUGUI RODRIGUEZ IGNACIO;EUGUIRODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 6191 , F 128, S 8, H SE 16067, I/A 63 (19.05.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOYTRE JUAN;MORENO PURROY FERNANDO MARIA;GOGORZA BERASATEGUICRISTINA. Apo.Manc.: DOMINGUEZ BORGE JUAN;CORREIA DA SILVA PAULO JORGE. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOYTREJUAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOYTRE JUAN;DE MOT LUDWIG;MEESSEN FREDERIC;DE SURVILLELOOC;MORENO PURROY FERNANDO MARIA;GOGORZA BERASATEGUI CRISTINA;DOMINGUEZ BORGES JUAN;CORREIA DASILVA PAULO. Datos registrales. T 6191 , F 128, S 8, H SE 16067, I/A 64 (22.05.17).
28 de Julio de 2016Nombramientos. Apoderado: GOGORZA BERASATEGUI CRISTINA. Datos registrales. T 6191 , F 127, S 8, H SE 16067, I/A 60(20.07.16).
24 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOYTRE JUAN. Apo.Manc.: BALTHAZARD GABRIEL;DE MOT LUDWIG;LUGOLBERTRAND;MEESSEN FREDERIC. Datos registrales. T 6191 , F 126, S 8, H SE 16067, I/A 59 (14.06.16).
06 de Junio de 2016Nombramientos. Consejero: LUGOL BERTRAND. Datos registrales. T 6191 , F 126, S 8, H SE 16067, I/A 58 (25.05.16).
11 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: BALTHAZARD GABRIEL. Consejero: BERGHMANS JEAN PIERRE. Con.Delegado: BERGHMANSJEAN PIERRE. Nombramientos. Presidente: DE MOT LUDWIG. Reelecciones. Consejero: MEESSEN FREDERIC. Datosregistrales. T 5400 , F 58, S 8, H SE 16067, I/A 56 ( 3.03.16).
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS TOTALMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CONTENIENDO EN NUEVO TEXTODE LOS MISMOS LOS ARTICULOS 1º A 33º, AMBOS INCLUSIVE.- . Datos registrales. T 5400 , F 58, S 8, H SE 16067, I/A 57 (3.03.16).
Otros conceptos: A los efectos del Art. 122.3 del R.R.M., se ha hecho constar que , con fecha 30/06/15, se ha emitido el TituloMúltiple número 1, representativo de 6.120.000 acciones, numeradas de la 1 a la 6.120.000 ambos inclusive, que integran la totalidaddel capital social.- Datos registrales. T 5400 , F 58, S 8, H SE 16067, I/A 57 b ( 3.03.16).
25 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: EUGUI RODRIGUEZ IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: ABOS ALDANONDO LAYA.VsecrNoConsj: IZAL SULTAN OLIVIER. Datos registrales. T 5400 , F 57, S 8, H SE 16067, I/A 55 (16.06.15).
07 de Enero de 2015Revocaciones. Auditor: HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 5400 , F 57, S 8, H SE 16067, I/A 54 (18.12.14).
09 de Octubre de 2013Nombramientos. Consejero: DE MOT LUDWIG. Datos registrales. T 5400 , F 57, S 8, H SE 16067, I/A 53 (30.09.13).
01 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 5076 , F 91, S 8, H SE 16067, I/A 52(17.07.13).
19 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: DOMINGUEZ BORGE JUAN. Datos registrales. T 5076 , F 89, S 8, H SE 16067, I/A 50 ( 6.02.13).
Nombramientos. Apo.Manc.: CORREIA DA SILVA PAULO JORGE. Datos registrales. T 5076 , F 90, S 8, H SE 16067, I/A 51 (6.02.13).
04 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: HANIN JEAN PIERRE. Datos registrales. T 5076 , F 88, S 8, H SE 16067, I/A 49 (25.01.13).
21 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: CHAVARRI AZCONA MARIA SAGRARIO. Aud.Supl.: HEVIA CHAVARRI BELEN. Consejero: BERGHMANSJEAN PIERRE;BALTHAZARD GABRIEL;HANIN JEAN PIERRE. Presidente: BALTHAZARD GABRIEL. Con.Delegado: BERGHMANSJEAN PIERRE. Datos registrales. T 5076 , F 87, S 8, H SE 16067, I/A 48 (10.09.12).
01 de Marzo de 2012Modificaciones estatutarias. 3. Administración y Representacion.-. 4. JUNTA GENERAL.. Datos registrales. T 5076 , F 84, S 8, HSE 16067, I/A 46 ( 6.02.12).
24 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORENO PURROY FERNANDO MARIA;IRISO FERNANDEZ IGNACIO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LUGOL BERTRAND;MORENO PURROY FERNANDO MARIA;GOGORZA BERASATEGUI CRISTINA. Datosregistrales. T 5076 , F 85, S 8, H SE 16067, I/A 47 ( 6.02.12).
08 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LHOIST LEON ALBERT. Datos registrales. T 5076 , F 84, S 8, H SE 16067, I/A 45 (22.06.11).
07 de Julio de 2011Reelecciones. Auditor: CHAVARRI AZCONA MARIA SAGRARIO. Aud.Supl.: HEVIA CHAVARRI BELEN. Datos registrales. T 5076 ,F 84, S 8, H SE 16067, I/A 44 (20.06.11).
19 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOYTRE JUAN. Datos registrales. T 5076 , F 83, S 8, H SE 16067, I/A 43 ( 6.07.10).
25 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MARCOS DE ACEVEDO FERREIRA FRANCA. Reelecciones. Consejero: MAURICE BOVAL.Auditor: CHAVARRI AZCONA MARIA SAGRARIO. Aud.Supl.: HEVIA CHAVARRI BELEN. Datos registrales. T 5076 , F 82, S 8, H SE16067, I/A 41 ( 2.06.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MAURICE BOVAL. Nombramientos. Consejero: MEESSEN FREDERIC. Reelecciones. Auditor:CHAVARRI AZCONA MARIA SAGRARIO. Aud.Supl.: HEVIA CHAVARRI BELEN. Datos registrales. T 5076 , F 82, S 8, H SE 16067,I/A 42 ( 8.06.10).
26 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: JOSE MIGUEL LANERO VEGA. Apoderado: JOSE MIGUEL LANERO VEGA. Datos registrales. T5076 , F 82, S 8, H SE 16067, I/A 40 (16.11.09).
29 de Mayo de 2009Nombramientos. Aud.Supl.: HEVIA CHAVARRI BELEN. Reelecciones. Auditor: CHAVARRI AZCONA MARIA SAGRARIO. Datosregistrales. T 2233 , F 136, S 8, H SE 16067, I/A 39 (18.05.09).