Actos BORME de Calaspasol 1 Sl
21 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PENTREATH NICHOLAS;DE LASERNA GOULD LUIS-JAIME;MOLINARI MIRKO PIETRO EMILIO;TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ;LACACI NUEVOFERNANDO;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;MOLINA DEL VALLE ELENA;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MOYA TRIGUERO FRANCISCO. Datos registrales. T 39236 , F 101, S 8, H M 433209, I/A 22 (12.04.22).
16 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: MONFORT CELDRAN JOAQUIN. Datos registrales. T 39236 , F 101, S 8, H M 433209, I/A 21 (9.03.22).
15 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 39236 , F 99, S 8, H M 433209, I/A 20 (7.10.21).
21 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 39236 , F 99, S 8, H M 433209, I/A 19(14.10.20).
15 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: MICO VALDENEBRO FERNANDO. Datos registrales. T 39236 , F 98, S 8, H M 433209, I/A 16 (7.10.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA. Datos registrales. T 39236 , F 98, S 8, H M 433209, I/A 17( 7.10.20).
Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO;PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 39236 , F 99, S 8, H M 433209,I/A 18 ( 7.10.20).
13 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO;MICO VALDENEBRO FERNANDO;DE LA SERNA GOULD LUISJAIME;PARADISO BENIAMINO;TIELVE MARTINEZ DE GUEREÑU BEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;RIBALLO FERNANDEZANTONIO ENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA. Datos registrales. T39236 , F 96, S 8, H M 433209, I/A 15 ( 5.10.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 39236 , F 96, S 8, H M 433209, I/A 14 (23.04.20).
28 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL 1 5ª (MADRID). Datos registrales. T 39236 , F 96, S 8, H M 433209, I/A13 (21.04.20).
17 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 39236 , F 95, S 8, H M 433209, I/A12 (10.10.19).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA. Datos registrales. T 24111 , F 128,S 8, H M 433209, I/A 11 (27.05.19).
02 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RIBERAS MERA JUAN MARIA;RIBERAS MERA FRANCISCO JOSE. Revocaciones. Apoderado:BARREDO LOPEZ JORGE;BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Adm. Unico: GESTAMP ASETYM SOLAR SL.Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios aAdministrador único. Datos registrales. T 24111 , F 128, S 8, H M 433209, I/A 10 (22.01.16).
23 de Mayo de 2011Cambio de domicilio social. C/ OMBU 3 2& (MADRID). Datos registrales. T 24111 , F 127, S 8, H M 433209, I/A 9 (11.05.11).
19 de Enero de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificado el articulo 23 de los estatutos - implicando el Cierre del Ejercicio.-.Datos registrales. T 24111 , F 127, S 8, H M 433209, I/A 8 ( 7.01.10).
16 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24111 , F 126, S 8, H M 433209, I/A 7 (26.08.09).
06 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: BARREDO LOPEZ JORGE. Datos registrales. T 24111 , F 125, S 8, H M 433209, I/A 6 (27.01.09).