Actos BORME de Calzados Apodos Sl
08 de Enero de 2020Reelecciones. Adm. Unico: CASTILLO MARTINEZ LOSA JOSE DAVID. Datos registrales. T 452 , F 116, S 8, H LO 6564, I/A 10(26.12.19).
12 de Febrero de 2015Reelecciones. Adm. Unico: CASTILLO MARTINEZ LOSA JOSE DAVID. Datos registrales. T 452 , F 116, S 8, H LO 6564, I/A 9(30.01.15).
18 de Octubre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 176,72 Euros. Resultante Suscrito: 14.000,00 Euros. Datos registrales. T 452 , F 116, S 8, H LO6564, I/A 8 ( 8.10.12).
26 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GARRIDO PEREZ SEVILLA PEDRO. Presidente: GARRIDO PEREZ SEVILLA PEDRO. Consejero:TOMAS TOMAS RAFAEL. Vicepresid.: TOMAS TOMAS RAFAEL. Consejero: OTEGUI MAS JUAN. Secretario: OTEGUI MAS JUAN.Consejero: MARTINEZ CASTILLO JESUS;CASTILLO MARTINEZ FELIX. Cons.Del.Man: OTEGUI MAS JUAN;GARRIDO PEREZSEVILLA PEDRO. Nombramientos. Adm. Unico: CASTILLO MARTINEZ LOSA JOSE DAVID. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 452 , F 115, S 8, H LO6564, I/A 6 (17.01.11).
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PEREZ SEVILLA PEDRO. Datos registrales. T 452 , F 115, S 8, H LO 6564, I/A 7(17.01.11).