Actos BORME de Camge Financiera E. F. C. Sa
17 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: OCHOA PEREZ SALVADOR;GALIANO ARACIL FRANCISCO JOSE;GALIAN VALLDENEUADRIA;SERRANO ESCOBEDO SERGIO;FIGUERAS MORENO ALBERT;FIGARO VOLTA ROSA;RODRIGUEZ CASTILLOFEDERICO. Presidente: GALIAN VALLDENEU ADRIA. SecreNoConsj: CASAS MARTINEZ. CARMEN. VocComAudit: MARTINEZGARCIA FRANCISCO JOSE;MIQUEU FRANCOIS XAVIER MARIE;MESEGUER TORRES JOAQUIN. SecComAudit: NAVAJASGARCIA FRANCISCO. Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Extinción. Datosregistrales. T 3542 , F 52, S 8, H A 89380, I/A 48 ( 5.12.12).
13 de Noviembre de 2012Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3542 , F 52, S 8, H A 89380, I/A47 (29.10.12).
06 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Datos registrales. T 3542 , F 51, S 8, H A 89380, I/A 46 (23.10.12).
10 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. Consejero: SALZER PETER CHRISTOPH. Vicepresid.:SALZER PETER CHRISTOPH. Consejero: SAVA BERTRAND;GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS;CARREÑO ALVAREZ DANIEL;LERMAFENOLL MANUEL JOSEP. Presidente: OCHOA PEREZ SALVADOR. VsecrNoConsj: PALOMAR PEREZ LUCAS. Nombramientos.SecreNoConsj: CASAS MARTINEZ. CARMEN. Consejero: GALIAN VALLDENEU ADRIA;SERRANO ESCOBEDOSERGIO;FIGUERAS MORENO ALBERT;FIGARO VOLTA ROSA;RODRIGUEZ CASTILLO FEDERICO. Presidente: GALIANVALLDENEU ADRIA. Datos registrales. T 3542 , F 51, S 8, H A 89380, I/A 45 ( 1.08.12).
07 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Consejero: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE.Nombramientos. Consejero: LERMA FENOLL MANUEL JOSEP. Presidente: OCHOA PEREZ SALVADOR. Datos registrales. T3542 , F 51, S 8, H A 89380, I/A 44 (26.07.12).
30 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Datos registrales. T 3542 , F 51, S 8, H A 89380, I/A 43 (18.07.12).
26 de Marzo de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOVER IRLES ELEUTERIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Datosregistrales. T 3542 , F 50, S 8, H A 89380, I/A 42 (13.03.12).
13 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ-GRANADOS RAFAEL. Nombramientos. Consejero: CARREÑO ALVAREZ DANIEL. Datosregistrales. T 3542 , F 50, S 8, H A 89380, I/A 41 ( 2.01.12).
01 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ BAEZA JOSE. Nombramientos. Consejero: GOMEZ GOMEZ JUAN JESUS. Datosregistrales. T 3542 , F 50, S 8, H A 89380, I/A 40 (21.11.11).
22 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3542 , F 50, S 8, H A 89380, I/A 39 (12.09.11).
02 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: BANCO CAM SA. Datos registrales. T 3024 , F 182, S 8, H A 89380, I/A 38 (21.07.11).
27 de Julio de 2011Nombramientos. Vicepresid.: SALZER PETER CHRISTOPH. Datos registrales. T 3024 , F 182, S 8, H A 89380, I/A 37 (13.07.11).
22 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DURAND XAVIER. Vicepresid.: DURAND XAVIER. Consejero: BURRULL EGEA FRANCESC.Nombramientos. Consejero: SAVA BERTRAND;DIAZ-GRANADOS RAFAEL. Datos registrales. T 3024 , F 182, S 8, H A 89380, I/A36 (12.07.11).
25 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: SITEL AGENTE FINANCIERO SA. Datos registrales. T 3024 , F 182, S 8, H A 89380, I/A 35(15.03.11).
24 de Marzo de 2011Cambio de domicilio social. RBLA MENDEZ NUÑEZ 15 3& (ALICANTE). Datos registrales. T 3024 , F 181, S 8, H A 89380, I/A 34(14.03.11).
02 de Diciembre de 2010Nombramientos. Vicepresid.: DURAND XAVIER. Datos registrales. T 3024 , F 181, S 8, H A 89380, I/A 33 (19.11.10).
01 de Diciembre de 2010Nombramientos. SecreNoConsj: PEREA ARRANZ PEDRO PABLO. VsecrNoConsj: PALOMAR PEREZ LUCAS. Datos registrales.T 3024 , F 181, S 8, H A 89380, I/A 32 (19.11.10).
30 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: O'SHEA DES. Vicepresid.: O'SHEA DES. Consejero: HUSS NICOLAS. Nombramientos. Consejero:DURAND XAVIER;SALZER PETER CHRISTOPH. Datos registrales. T 3024 , F 181, S 8, H A 89380, I/A 30 (19.11.10).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PALOMAR PEREZ LUCAS. VsecrNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ DE OCHOA MARIA DEL MAR.Datos registrales. T 3024 , F 181, S 8, H A 89380, I/A 31 (19.11.10).
09 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: JOVER IRLES ELEUTERIO;BALDWIN GREGORY. Datos registrales. T 3024 , F 162, S 8, H A 89380,I/A 29 (25.03.10).
08 de Abril de 2010Reelecciones. Consejero: GALIANO ARACIL FRANCISCO JOSE;MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Presidente: MARTINEZGARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3024 , F 161, S 8, H A 89380, I/A 27 (25.03.10).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ SALINAS DOMINGO LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOVER IRLESELEUTERIO;BALDWIN GREGORY. Datos registrales. T 3024 , F 162, S 8, H A 89380, I/A 28 (25.03.10).
03 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GAMUCCI GIUSEPPE. Vicesecret.: PALOMAR PEREZ LUCAS. Nombramientos.SecreNoConsj: PALOMAR PEREZ LUCAS. VsecrNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ DE OCHOA MARIA DEL MAR. Datos registrales.T 3024 , F 161, S 8, H A 89380, I/A 26 (23.10.09).
20 de Mayo de 2009Fe de erratas: Rectificado el nombre del Presidente del Consejo de Administración, siendoel mismo don Francisco José MartínezGarcía. Datos registrales. T 3024 , F 161, S 8, H A 89380, I/A 25 (30.03.09).
08 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN YAÑEZ FERNANDO. Presidente: LOPEZ ABAD ROBERTO. Consejero: LOPEZ ABADROBERTO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ BAEZA JOSE;OCHOA PEREZ SALVADOR. Presidente: GALIANO ARACILFRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 3024 , F 161, S 8, H A 89380, I/A 25 (30.03.09).