Actos BORME de Candyfive Sl
17 de Mayo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.502,53 Euros. Resultante Suscrito: 1.502,53 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:1.502,53 Euros. Resultante Suscrito: 3.005,06 Euros. Datos registrales. T 24324 , F 216, S 8, H B 67903, I/A 11 ( 8.05.19).
01 de Febrero de 2019Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: SANCHEZ MORALES MANUEL. Datos registrales. T 24324 , F 216, S 8, H B 67903, I/A 10(25.01.19).
26 de Enero de 2018Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JIMENEZ VISO JESUS. Datos registrales. T 24324 , F 215, S 8, H B 67903, I/A 9 (18.01.18).
17 de Enero de 2017Revocaciones. CONSEJERO: LOPEZ PINAZO JORGE. CONS. DELEG.: LOPEZ PINAZO JORGE. CONSEJERO: JIMENEZ VISOJESUS. PRESIDENTE: JIMENEZ VISO JESUS. CONS. DELEG.: JIMENEZ VISO JESUS. CONSEJERO: ORTEGA EXPOSITO JUANJOSE. SECRETARIO: ORTEGA EXPOSITO JUAN JOSE. CONS. DELEG.: ORTEGA EXPOSITO JUAN JOSE. CONSEJERO:SANCHEZ MORALES MANUEL. CONS. DELEG.: SANCHEZ MORALES MANUEL. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: LOPEZPINAZO JORGE;JIMENEZ VISO JESUS;SANCHEZ MORALES MANUEL. Datos registrales. T 24324 , F 215, S 8, H B 67903, I/A 8 (9.01.17).
03 de Julio de 2013Modificaciones estatutarias. ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 24324 , F 215, S 8, H B 67903, I/A 7 (25.06.13).