Buscador CIF Logo

Actos BORME Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa

Actos BORME Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa - A85360766

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa con CIF A85360766

馃敊 Perfil de Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cantabria Capital Sociedad De Participaciones Preferentes Sa

17 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: NORTE脩A PATRIMONIAL SL;CAMIN DE LA MESA SA. Representan: RENA SANCHEZ ANAMARIA;JIMENO GARCIA ALVARO. Nombramientos. Representan: RENA SANCHEZ ANA MARIA. LiquiSoli: NORTE脩APATRIMONIAL SL;CAMIN DE LA MESA SA. Representan: JIMENO GARCIA ALVARO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 25485 , F 47, S 8, H M 459173, I/A 16 (10.12.19).

21 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CASTRO COBO BARBARA. Consejero: PICO CORTES SL;PUERTU MARAVIO SL;SIERRA DELACEBO SL. Presidente: SIERRA DEL ACEBO SL. Con.Delegado: SIERRA DEL ACEBO SL. Representan: CRESPO GARCIAMARGARITA;MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE;MARTINEZ SECADES ANDRES Nombramientos. Representan: RENASANCHEZ ANA MARIA. Adm. Solid.: NORTE脩A PATRIMONIAL SL;CAMIN DE LA MESA SA. Representan: JIMENO GARCIAALVARO. Modificaciones estatutarias. COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION, SEMODIFICAN LOS ARTICULOS 36潞 Y 37潞 DE LOS ESTATUTOS Y, SE DEJAN SIN EFECTO, LOS ARTICULOS 40 A 47, AMBOSINCLUSIVE.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.Datos registrales. T 25485 , F 46, S 8, H M 459173, I/A 15 (14.11.18).

07 de Abril de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ TEJEDA EUGENIO. Apo.Sol.: ARANGUEZ CORTES ANA;SANCHEZ TEJEDA EUGENIO.Datos registrales. T 25485 , F 46, S 8, H M 459173,0 , I/ 14 .(31.03.16).

20 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: ZUBIETA SUBIRANA ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: CASTRO COBO BARBARA. Datosregistrales. T 25485 , F 46, S 8, H M 459173,0 , I/ 13 .(13.01.16).

22 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: DIEZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO. Nombramientos. Representan: MARTINEZ SECADESANDRES. Datos registrales. T 25485 , F 45, S 8, H M 459173,0 , I/ 12 .(14.07.15).

14 de Julio de 2015
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LAS INSCRIPCIONES 5& Y 8& EL NOMBRAMIENTO DE DIAZ FERNANDEZ JORGEALBERTO COMO REPRESENTANTE Y APODERADO RESPECTIVAMENTE, SIENDO LO CORRECTO DIEZ FERNANDEZ JORGEALBERTO. Datos registrales. T 25485 , F 42, S 8, H M 459173,0 , I/ 5 .(29.06.12).

02 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALDES CID JORGE;RUBIO VALLINA CARLOS;SANCHEZ TEJEDA EUGENIO. Datos registrales.T 25485 , F 45, S 8, H M 459173,0 , I/ 10 .(25.08.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: ARANGUEZ CORTES ANA;SANCHEZ TEJEDA EUGENIO. Datos registrales. T 25485 , F 45, S 8, H M459173,0 , I/ 11 .(25.08.14).

12 de Mayo de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LIBERBANK SA. Datos registrales. T 25485 , F 44, S 8, H M459173,0 , I/ 9 .(30.04.14).

10 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ANDRES LUIS FERNANDO;GARCIA ESPERANZA JAVIER;GUTIERREZ RODRIGUEZALFONSO MARIA;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE. Presidente: GARCIA ANDRES LUISFERNANDO. Consejero: PASTOR VALLE ROBERTO. Revocaciones. Apoderado: GARCIA ANDRES LUIS FERNANDO;PASTORVALLE ROBERTO;GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA;GARCIA ANDRES FERNANDO;PASTOR VALLEROBERTO;GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA Nombramientos. Consejero: PICO CORTES SL;PUERTU MARAVIOSL;SIERRA DEL ACEBO SL. Representan: CRESPO GARCIA MARGARITA. Presidente: SIERRA DEL ACEBO SL. Con.Delegado:SIERRA DEL ACEBO SL. Representan: MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE;DIAZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO. Datosregistrales. T 25485 , F 42, S 8, H M 459173,0 , I/ 5 .(29.06.12).

Nombramientos. Apoderado: CASTRO COBO CRISTINA. Datos registrales. T 25485 , F 43, S 8, H M 459173,0 , I/ 6 .(29.06.12).

Nombramientos. Apoderado: CRESPO GARCIA MARGARITA. Datos registrales. T 25485 , F 44, S 8, H M 459173,0 , I/ 7.(29.06.12).

Nombramientos. Apoderado: DIAZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO. Datos registrales. T 25485 , F 44, S 8, H M 459173,0 , I/ 8.(29.06.12).

02 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25485 , F 42, S 8, H M 459173,0 , I/ 4 .(23.01.12).

10 de Marzo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ERASO MAESO VICTOR JAVIER. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION3&, LA PUBLICACION DE LA DIMISION COMO CONSEJERO DE ERASO MAESO VICTOR JAVIER. Datos registrales. T 25485 , F42, S 8, H M 459173,0 , I/ 3 .(22.06.10).

01 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MADRAZO JOSE ANTONIO. Reelecciones. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25485 , F 42, S 8, H M 459173,0 , I/ 3 .(22.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n