Actos BORME de Cantabria Vida Y Pensiones Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros
16 de Febrero de 2015Extinción. Datos registrales. T 1020 , F 11, S 8, H S 19595, I/A 35 ( 6.02.15).
22 de Octubre de 2014Otros conceptos: Cesado don Alvaro Vaca Atienza como representante persona física de PICO CORTES, SL y nombrada en sulugar doña Ana Aranguez Cortés. Datos registrales. T 1020 , F 10, S 8, H S 19595, I/A 32 (15.10.14).
Otros conceptos: Cesada doña Ana Aranguez Cortés como representante persona física de PICO CORTES, SL y nombrado en sulugar don Rodrigo Jesús Fernández-Avello García-Tuñón. Datos registrales. T 1020 , F 10, S 8, H S 19595, I/A 33 (15.10.14).
Otros conceptos: Cesado don Rodrigo Jesús Fernández-Avello García-Tuñón como representante persona física de PICOMIRAVALLES, SL y nombrada en su lugar doña Ana Aranguez Cortés. Datos registrales. T 1020 , F 11, S 8, H S 19595, I/A 34(15.10.14).
24 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: PLAZA LOPEZ-BERGES MARIO. Datos registrales. T 1020 , F 10, S 8, H S 19595, I/A 31 (17.02.14).
20 de Agosto de 2013Otros conceptos: Cesado don Damiaan Frans Rudolf Jacobovits como representante persona física de "AEGON SPAIN HOLDINGB.V." y nombrado, en su lugar, don TIBOR-RUDOLF LEEUWENBURGH. Datos registrales. T 1020 , F 10, S 8, H S 19595, I/A 30 (8.08.13).
04 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: MONTES MUÑOZ JUAN JOSE;RUIZ TORRES LUIS ANGEL;MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCOJOSE;KIRKPATRICK DE LA VEGA JAIME;ALFARO URIARTE TOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ TORRES LUISANGEL. Apo.Manc.: ALFARO URIARTE TOMAS;MENDEZ SUAREZ SEVERINO JESUS;GONZALEZ PEREZ SAUL. Datosregistrales. T 1020 , F 9, S 8, H S 19595, I/A 29 (28.06.13).
22 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ-ARDA CRIADO JAVIER. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ LOPEZ OCHOA MAR.Datos registrales. T 1020 , F 8, S 8, H S 19595, I/A 28 (14.05.13).
14 de Mayo de 2013Otros conceptos: D. Ignacio Ayala Soto es sustituído por D. Saúl González Pérez como representante persona física del consejeroQuality Medical Services SL.- Datos registrales. T 1020 , F 8, S 8, H S 19595, I/A 27 ( 7.05.13).
11 de Marzo de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: CAMPS SANDIN MANUEL;SANCHEZ ROMERO JOSE FRANCISCO;TEJERINA ALBA ALFONSO.Otros conceptos: Se REVOCAN exclusivamente en cuanto al ejercicio de las facultades de Nivel 2 los poderes conferidos a DONJOSE-FRANCISCO SANCHEZ ROMERO y DON ALFONSO TEJERINA ALBA, en escritura de fecha 20 de junio de 2012, del Notariode Madrid D. Salvador Miras Gómez, nº 1126, por la inscripción 21&. Datos registrales. T 1020 , F 8, S 8, H S 19595, I/A 26 (4.03.13).
08 de Febrero de 2013Otros conceptos: El consejero AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS nombracomo nuevo representante personafísica a D. JAIME KIRKPATRICK DE LA VEGA, en sustitución de D. Jesús Quintanal San Emeterio.-El consejero AEGON SPAINHOLDING BV nombra como nuevorepresentante persona física a D. DAMIAN FRANS RUDOLF JACOBOVITS DE SZEGED, ensustitución de D. Jaime Kirkpatrick de la Vega.- Datos registrales. T 1020 , F 7, S 8, H S 19595, I/A 25 (30.01.13).
22 de Enero de 2013Nombramientos. Consejero: QUALITY MEDICAL SERVICE SL;TIATORDOS SA. Otros conceptos: Se modifican los artículos 1, 6,7, 11, 12, 15, 18, 20, 22,24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 36 y 38 de los estatutos sociales.-Se redacta el texto refundido de los estatutossociales.-El consejero PICO MIRAVALLES SL sustituye a su anterior representante, D. Severino Jesús Méndez Suárez, siendo sunuevorepresentante persona física don Rodrigo Fernández-Avello García-Tuñón.- Datos registrales. T 1020 , F 4, S 8, H S 19595, I/A23 ( 9.01.13).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: REGO LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. Vicesecret.: PUERTU MARAVIO SL. Datosregistrales. T 1020 , F 7, S 8, H S 19595, I/A 24 ( 9.01.13).
14 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: ERASO MAESO VICTOR JAVIER;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;CORPACHO BAZAGA JOSE LUIS.Nombramientos. Apoderado: CAMPS SANDIN MANUEL;PINTOR ALONSO ANGEL-ANTONIO. Datos registrales. T 1020 , F 4, S8, H S 19595, I/A 20 (31.10.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: TEJERINA ALBA ALFONSO;SANCHEZ ROMERO FRANCISCO. Apoderado: MARTIN CRESPOAURORA. Apo.Sol.: SAN ROMAN MARTINEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 1020 , F 4, S 8, H S 19595, I/A 21 (31.10.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ROMERO FRANCISCO;CAMPS SANDIN MANUEL. Datos registrales. T 1020 , F 4, S 8, H S19595, I/A 22 (31.10.12).
09 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ERASO MAESO VICTOR JAVIER. Presidente: ERASO MAESO VICTOR JAVIER. Consejero:MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE;AEGON SEGUROS DE VIDA AHORRO E INVERSION SA. Nombramientos.Consejero: PICO CORTES SL. Presidente: PICO CORTES SL. Consejero: PICO MIRAVALLES S.L.;PUERTU MARAVIOSL;CAVANILLES SA;AEGON ESPANJE HOLDING BV. Reelecciones. Consejero: AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS YREASEGUROS. Vicepresid.: AEGON ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Otros conceptos: Se modifica el artículo 20 delos estatutos sociales relativo a la estructura del órgano de administración.Se fija en seis el número de miembros del Consejo deAdministración. Datos registrales. T 1020 , F 3, S 8, H S 19595, I/A 18 (30.07.12).
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.507.591,00 Euros. Datos registrales. T 1020 , F 3, S 8, H S 19595, I/A 19(30.07.12).
01 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 1020 , F 2, S 8, H S 19595, I/A 16 (21.11.11).
Nombramientos. Apoderado: ERASO MAESO VICTOR JAVIER;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;PEREA FERNANDEZ PACHECOIGNACIO;GONZALEZ PEREZ SAUL;PEREZ DEL PALACIO EDUARDO;CORPACHO BAZAGA JOSE LUIS;GUTIERREZ DE GRANDAMARIA;SAN ROMAN MARTINEZ MARIA LUISA;CABANILLAS CABANILLAS JOSE. Datos registrales. T 1020 , F 2, S 8, H S 19595,I/A 17 (22.11.11).
25 de Octubre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ TORRES LUIS ANGEL;MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE;KIRKPATRICK DE LAVEGA JAIME. Apo.Manc.: GONZALEZ PEREZ SAUL;CAMPO GARCIA ALBERTO;GUTIERREZ DE GRANDA MARIA;CORPACHOBAZAGA JOSE LUIS;ERASO MAESO VICTOR JAVIER;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;PEREA FERNANDEZ PACHECOIGNACIO;GONZALEZ PEREZ SAUL. Datos registrales. T 1020 , F 1, S 8, H S 19595, I/A 14 (13.10.11).
Nombramientos. Apoderado: RUIZ TORRES LUIS ANGEL;MARTINEZ SAMPEDRO FRANCISCO JOSE;KIRKPATRICK DE LAVEGA JAIME;ALFARO URIARTE TOMAS. Datos registrales. T 1020 , F 1, S 8, H S 19595, I/A 15 (13.10.11).
12 de Julio de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ERASO MAESO VICTOR JAVIER;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;PEREA FERNANDEZ PACHECOIGNACIO;LEON DORADO JOSE-RAUL. Apo.Sol.: LEON DORADO JOSE-RAUL;GUTIERREZ DE GRANDA MARIA;GUTIERREZ DEGRANDA MARIA;MONTES MUÑOZ JUAN JOSE;MONTES MUÑOZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 931 , F 7, S 8, H S 19595, I/A11 ( 1.07.10).
Nombramientos. Apo.Manc.: ERASO MAESO VICTOR JAVIER;DE LUIS MARCOS JOSE LUIS;PEREA FERNANDEZ PACHECOIGNACIO;GONZALEZ PEREZ SAUL. Datos registrales. T 931 , F 7, S 8, H S 19595, I/A 12 ( 1.07.10).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ PEREZ SAUL;GUTIERREZ DE GRANDA MARIA;MONTES MUÑOZ JUAN JOSE. Datosregistrales. T 931 , F 7, S 8, H S 19595, I/A 13 ( 1.07.10).
30 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ TORRES LUIS ANGEL;ERASO MAESO VICTOR JAVIER;KIRKPATRICK DE LA VEGA JAIME.Datos registrales. T 931 , F 6, S 8, H S 19595, I/A 10 (19.11.09).
21 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LUIS MARCOS JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: AEGON SEGUROS DE VIDAAHORRO E INVERSION SA. Datos registrales. T 931 , F 6, S 8, H S 19595, I/A 9 (12.08.09).
22 de Junio de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: LEON DORADO JOSE-RAUL;GUTIERREZ DE GRANDA MARIA;GUTIERREZ DE GRANDAMARIA;MONTES MUÑOZ JUAN JOSE;MONTES MUÑOZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 931 , F 6, S 8, H S 19595, I/A 8 (8.06.09).
09 de Febrero de 2009Nombramientos. Consejero: REGO LOPEZ ANTONIO. Modificaciones estatutarias. Modificado el Artículo 24 de los Estatutosque contemplará, en adelante, la figura del Vicesecretario del Consejo de Administración.. Datos registrales. T 931 , F 5, S 8, H S19595, I/A 7 (27.01.09).
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 931 , F 5, S 8, H S 19595, I/A 8 (27.01.09).