Buscador CIF Logo

Actos BORME Cantelec Burgos Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cantelec Burgos Sociedad Anonima

Actos BORME Cantelec Burgos Sociedad Anonima - A39077839

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Burgos para Cantelec Burgos Sociedad Anonima con CIF A39077839

馃敊 Perfil de Cantelec Burgos Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Burgos

Actos BORME de Cantelec Burgos Sociedad Anonima

23 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Cons.Del.Sol: GOMEZ-CASUSO SERNA MANUEL ANGEL;NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Consejero:NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Presidente: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Consejero: GOMEZ-CASUSO SERNAMARIA DEL MAR. Vicepresid.: GOMEZ-CASUSO SERNA MARIA DEL MAR. Consejero: GOMEZ CASUSO SERNA LUCIA.Secretario: GOMEZ CASUSO SERNA LUCIA. Consejero: GOMEZ-CASUSO SERNA MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 1163 , F61, S 8, H S 3097, I/A 20 (14.12.22).

27 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: NAVARRO LEBANIEGOS ADOLFO. Datos registrales. T 1163 , F 61, S 8, H S 3097, I/A 19(18.04.18).

11 de Agosto de 2017
Reelecciones. Consejero: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Presidente: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Consejero:GOMEZ-CASUSO SERNA MARIA DEL MAR. Vicepresid.: GOMEZ-CASUSO SERNA MARIA DEL MAR. Consejero: GOMEZ CASUSOSERNA LUCIA. Secretario: GOMEZ CASUSO SERNA LUCIA. Consejero: GOMEZ CASUSO SERNA MANUEL ANGEL. Cons.Del.Sol:NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES;GOMEZ CASUSO SERNA MANUEL ANGEL. Datos registrales. T 478 , F 16, S 8, H S 3097,I/A 18 ( 3.08.17).

11 de Mayo de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 9.015,19 Euros. Resultante Suscrito: 81.136,63 Euros. Datos registrales. T 478 , F 16, S8, H S 3097, I/A 17 ( 5.05.17).

25 de Enero de 2017
Revocaciones. Auditor: CIFRIAN QUEVEDO RAMON. Aud.Supl.: DE LA FUENTE PORRES MANUEL. Datos registrales. T 478 , F16, S 8, H S 3097, I/A 16 (17.01.17).

29 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Auditor: CIFRIAN QUEVEDO RAMON. Aud.Supl.: DE LA FUENTE PORRES MANUEL. Datos registrales. T 478 ,F 16, S 8, H S 3097, I/A 15 (21.09.15).

04 de Abril de 2014
Nombramientos. Auditor: ZAMBRANA LEDESMA JORGE. Datos registrales. T 478 , F 16, S 8, H S 3097, I/A 14 (31.03.14).

16 de Abril de 2013
Nombramientos. Auditor: ZUAZNABAR SEGURA MIKEL. Datos registrales. T 478 , F 16, S 8, H S 3097, I/A 13 ( 8.04.13).

13 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Consejero: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Presidente: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Consejero:GOMEZ CASUSO SERNA MARIA DEL MAR. Vicepresid.: GOMEZ CASUSO SERNA MARIA DEL MAR. Consejero: GOMEZ CASUSOSERNA LUCIA. Secretario: GOMEZ CASUSO SERNA LUCIA. Consejero: GOMEZ CASUSO SERNA MANUEL ANGEL. Datosregistrales. T 478 , F 15, S 8, H S 3097, I/A 11 ( 3.09.12).

Reelecciones. Cons.Del.Sol: NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES;GOMEZ CASUSO SERNA MANUEL ANGEL. Datosregistrales. T 478 , F 15, S 8, H S 3097, I/A 12 ( 3.09.12).

26 de Junio de 2012
Nombramientos. Cons.Del.Sol: GOMEZ CASUSO SERNA MANUEL ANGEL;NAVARRO GONZALEZ JOSE ANDRES. Datosregistrales. T 478 , F 15, S 8, H S 3097, I/A 10 (12.06.12).

07 de Febrero de 2012
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 17 de los estatutos sociales en cuanto a la retribuci贸n del consejo deadministraci贸n.. Datos registrales. T 478 , F 15, S 8, H S 3097, I/A 9 (24.01.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n