Actos BORME de Canteras Del Factor Sl
04 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ LOPEZ JOSE MIGUEL;SEGURA SANCHEZ LUIS MIGUEL. Vicepresid.: SANCHEZLOPEZ JOSE MIGUEL. Secretario: SEGURA SANCHEZ LUIS MIGUEL. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8, H A 158983, I/A 11(27.12.22).
24 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: RUEDA MIRA REMEDIOS MARIA;GARCIA RUIZ JUAN PEDRO. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8,H A 158983, I/A 10 (16.03.20).
16 de Marzo de 2020Fe de erratas: Error en la fecha del nombramiento de don Juan Ignacio Dionis Trenor como consejero, presidente y consejerodelegado, que consta en la inscripci贸n 9陋, siendo la correcta 04/11/2019 Error en la fecha de la dimisi贸n de don Fernando Arauz deRobles Villal贸n que consta en la inscripci贸n 9陋, siendo la correcta 14/10/2019. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8, H A 158983, I/A9 ( 2.01.20).
13 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Presidente: ARAUZ DE ROBLES VILLALONFERNANDO. Con.Delegado: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Nombramientos. Consejero: DIONIS TRENOR JUAN.Presidente: DIONIS TRENOR JUAN. Con.Delegado: DIONIS TRENOR JUAN. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8, H A 158983,I/A 9 ( 2.01.20).
03 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: RUEDA MIRA REMEDIOS MARIA. Datos registrales. T 4135 , F 154, S 8, H A 158983, I/A 8(22.06.18).
28 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: RAMON BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO. Datos registrales. T 4105 , F 34, S 8, H A158983, I/A 6 (20.06.18).
Nombramientos. Apoderado: ROBLES SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 4105 , F 34, S 8, H A 158983, I/A 7 (21.06.18).
27 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ BLANCO PABLO JOSE. Datos registrales. T 4105 , F 33, S 8, H A 158983, I/A 5(20.06.18).
25 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA RUIZ JUAN PEDRO. Datos registrales. T 4105 , F 33, S 8, H A 158983, I/A 4 (18.06.18).
22 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: BLANES DOMENECH EDUARDO. Datos registrales. T 4105 , F 32, S 8, H A 158983, I/A 3(15.06.18).
18 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Presidente: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL.Con.Delegado: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Vicesecret.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Nombramientos.Consejero: ROBLES SANCHEZ JOSE. Vicesecret.: ROBLES SANCHEZ JOSE. Presidente: ARAUZ DE ROBLES VILLALONFERNANDO. Con.Delegado: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Cambio de domicilio social. AUTOV MADRID-ALICANTE Km 382 (NOVELDA). Datos registrales. T 4105 , F 32, S 8, H A 158983, I/A 2 (10.05.18).
07 de Marzo de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 5.11.14. Objeto social: a - La exploraci贸n, investigaci贸n, explotaci贸n, aprovechamiento ytratamiento de toda clase de recursos mineros. b - El asesoramiento t茅cnico y realizaci贸n de proyectos, anteproyectos, estudios,direcci贸n, contrataci贸n, subcontrataci贸n y ejecuci贸n de todo tipo de obras y servicios relacionados con l. Domicilio: PRAJE CAMPET 10(NOVELDA). Capital: 20.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO;SANCHEZLOPEZ JOSE MIGUEL;SEGURA SANCHEZ LUIS MIGUEL;LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Presidente: LOPEZ-APARICIOAREILZA RAFAEL. Vicepresid.: SANCHEZ LOPEZ JOSE MIGUEL. Secretario: SEGURA SANCHEZ LUIS MIGUEL. Vicesecret.:ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Con.Delegado: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Datos registrales. T 4105 , F30, S 8, H A 158983, I/A 1 (26.02.18).