Actos BORME de Canteras Faber Sl
16 de Agosto de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: FAYOS LLOBREGAT JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: FAYOS CAZORLA ELENA.Reelecciones. Consejero: FAYOS LLOBREGAT JOSE MARIA. Datos registrales. T 4599 , F 142, S 8, H A 10053, I/A 45 ( 7.08.23).
14 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: ALONSO GERIZ BEATRIZ. Apo.Manc.: ALONSO GERIZ BEATRIZ;BORJA ALVAREZ DE TOLEDOANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 4483 , F 32, S 8, H A 10053, I/A 44 ( 4.08.23).
25 de Julio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: GRANT PAUL-DORIANT. Apoderado: GRANT PAUL-DORIANT. Datos registrales. T 4483 , F 32, S 8, HA 10053, I/A 43 (17.07.23).
23 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: GRANT PAUL-DORIANT. Apo.Manc.: GRANT PAUL-DORIANT;BORJA ALVAREZ DE TOLEDOANTONIO-RAMON;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 3813 , F 173, S 8, H A 10053, I/A 42 (15.06.22).
01 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ BLANCO PABLO JOSE. Consejero: VIVAS PEREZ MIGUEL. Nombramientos.Consejero: SANCHEZ BLANCO PABLO JOSE. Secretario: SANCHEZ BLANCO PABLO JOSE. Reelecciones. Consejero: FAYOSALVAREZ ANTONIO;FAYOS CAZORLA ELENA. Datos registrales. T 3813 , F 95, S 8, H A 10053, I/A 41 (21.02.22).
16 de Junio de 2020Reelecciones. Consejero: ROBLES SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 3813 , F 95, S 8, H A 10053, I/A 40 ( 2.06.20).
23 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: RUEDA MIRA REMEDIOS MARIA. Datos registrales. T 3813 , F 95, S 8, H A 10053, I/A 39 (13.03.20).
31 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO;MORENO GARCIA LUIS ALBERTO. Vicepresid.:ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Con.Delegado: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Nombramientos.Consejero: DIONIS TRENOR JUAN IGNACIO. Vicepresid.: DIONIS TRENOR JUAN IGNACIO. Con.Delegado: DIONIS TRENOR JUANIGNACIO. Consejero: VIVAS PEREZ MIGUEL. Datos registrales. T 3813 , F 95, S 8, H A 10053, I/A 38 (23.01.20).
03 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA. Vicepresid.: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROSSA. Con.Delegado: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA. Nombramientos. Consejero: MORENO GARCIA LUIS ALBERTO.Vicepresid.: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Con.Delegado: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO. Datosregistrales. T 3813 , F 95, S 8, H A 10053, I/A 37 (24.08.18).
11 de Julio de 2018Reelecciones. Consejero: FAYOS LLOBREGAT JOSE MARIA. Presidente: FAYOS LLOBREGAT JOSE MARIA. Datos registrales.T 3813 , F 94, S 8, H A 10053, I/A 36 ( 3.07.18).
28 de Junio de 2018Fe de erratas: La fecha de nombramiento del consejero nombrado por la inscripci贸n 25陋, es la del 21 de enero de 2013 y no la queconsta publicada. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 25 (21.02.13).
Fe de erratas: La fecha de nombramiento del consejero nombrado por la inscripci贸n 29陋, es la del 15 de octubre de 2014, y no la queconsta publicada. Datos registrales. T 3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 29 (11.11.14).
10 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: RUEDA MIRA REMEDIOS MARIA. Datos registrales. T 3813 , F 94, S 8, H A 10053, I/A 35 ( 2.05.18).
09 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: CAPILLA TOBAJAS JULIAN. Datos registrales. T 3813 , F 94, S 8, H A 10053, I/A 34 (27.04.18).
19 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: GIL HERNANDEZ DANIEL. Datos registrales. T 3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 33 (11.05.17).
18 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: COUTO VIVAS JORGE JAVIER. Apo.Manc.: COUTO VIVAS JORGE JAVIER. Datos registrales. T3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 32 (10.05.17).
06 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Vicepresid.: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL.Con.Delegado: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Nombramientos. Consejero: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA.Vicepresid.: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA. Con.Delegado: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA. Datosregistrales. T 3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 31 (22.02.17).
25 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOS RIZO ANTONIO;FAYOS RIZO FRANCISCO. Presidente: FAYOS RIZO ANTONIO.Nombramientos. Consejero: FAYOS ALVAREZ ANTONIO;FAYOS CAZORLA ELENA. Presidente: FAYOS LLOBREGAT JOSEMARIA. Datos registrales. T 3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 30 (18.04.16).
18 de Noviembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: VIVAS PEREZ MIGUEL. SecreNoConsj: MAESTRE PEREA YOLANDA. Nombramientos.Consejero: ARAUZ DE ROBLES VILLALON FERNANDO;ROBLES SANCHEZ JOSE. SecreNoConsj: SANCHEZ BLANCO PABLOJOSE. Datos registrales. T 3813 , F 93, S 8, H A 10053, I/A 29 (11.11.14).
17 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: CAPILLA TOBAJAS JULIAN. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 28 (10.11.14).
09 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ROBLES SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 27 ( 2.04.14).
01 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: PEREZ DE LA MUELA JESUS. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 26 (25.03.14).
28 de Febrero de 2013Reelecciones. Consejero: FAYOS RIZO ANTONIO;FAYOS RIZO FRANCISCO;FAYOS LLOBREGAT JOSE MARIA. Presidente:FAYOS RIZO ANTONIO. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 25 (21.02.13).
08 de Enero de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ SALA JUAN ANTONIO;FAYOS ALVAREZ ANTONIO. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, HA 10053, I/A 24 (31.12.12).
03 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIANO. Datos registrales. T 3261 , F 151, S 8, H A 10053, I/A 23(22.11.12).
30 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PEREZ DE LA MUELA JESUS. Datos registrales. T 3261 , F 150, S 8, H A 10053, I/A 21 (21.11.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: BORJA ALVAREZ DE TOLEDO ANTONIO RAMON;GARCIA RUIZ JUAN PEDRO;COUTO VIVASJORGE JAVIER;MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN;JUAN POLO JOSE;LEON DARDER FERNANDO. Datos registrales. T 3261 ,F 150, S 8, H A 10053, I/A 22 (21.11.12).
29 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PEREZ DE LA MUELA JESUS. Consejero: PEREZ DE LA MUELA JESUS. Nombramientos.Con.Delegado: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Datos registrales. T 3261 , F 150, S 8, H A 10053, I/A 20 (20.11.12).
08 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIANO. Nombramientos. SecreNoConsj: MAESTRE PEREAYOLANDA. Datos registrales. T 3261 , F 70, S 8, H A 10053, I/A 19 (27.09.12).
21 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PINOS ZAMORA ANTONIO JOSE. Vicepresid.: PINOS ZAMORA ANTONIO JOSE. Nombramientos.Consejero: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Vicepresid.: LOPEZ-APARICIO AREILZA RAFAEL. Datos registrales. T 3261 , F70, S 8, H A 10053, I/A 18 ( 9.05.12).
21 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MESA SANZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: VIVAS PEREZ MIGUEL. Datos registrales.T 3261 , F 70, S 8, H A 10053, I/A 17 (12.12.11).
20 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MOYA DOMENECH JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: MESA SANZ ALBERTO. Datosregistrales. T 3261 , F 70, S 8, H A 10053, I/A 16 (10.03.09).
06 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: COUTO VIVAS JORGE JAVIER. Datos registrales. T 3261 , F 69, S 8, H A 10053, I/A 15 (28.01.09).
04 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MANERO VICTOR JUAN. Datos registrales. T 3261 , F 69, S 8, H A 10053, I/A 14(26.01.09).
03 de Febrero de 2009Cambio de domicilio social. AUTOV MADRID-ALICANTE Km 382 (NOVELDA). Datos registrales. T 3261 , F 68, S 8, H A 10053,I/A 13 (23.01.09).
30 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIANO. Datos registrales. T 3261 , F 68, S 8, H A 10053, I/A 12(21.01.09).