Buscador CIF Logo

Actos BORME Canteras La Belonga Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Canteras La Belonga Sa

Actos BORME Canteras La Belonga Sa - A33026725

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Asturias para Canteras La Belonga Sa con CIF A33026725

馃敊 Perfil de Canteras La Belonga Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Asturias

Actos BORME de Canteras La Belonga Sa

27 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, H AS 1263, I/A 53(16.03.23).

20 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: REGINSTER MAXIME;LOPEZ GUERRA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, HAS 1263, I/A 51 (13.02.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: REGINSTER MAXIME. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, H AS 1263, I/A 52 (13.02.23).

10 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ IGLESIAS JUAN SATURNINO. Apo.Sol.: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUANJESUS;VILLAVERDE BARCALA ROGELIO;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Apoderado:FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ARISTONDO SORALUCEGREGORIO. Apo.Manc.: DIAZ VILLA MANUEL;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Apoderado: IBARZABAL OSET JOSE LUIS.Nombramientos. Apo.Sol.: REGINSTER MAXIME. Apo.Manc.: REGINSTER MAXIME. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS1263, I/A 49 (30.09.22).

16 de Agosto de 2022
Modificaciones estatutarias. 27. Organizaci贸n y de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS1263, I/A 48 ( 8.08.22).

10 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS 1263, I/A 47(30.11.21).

03 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Consejero: DIAZ MARTINEZ ANDRES;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 198,S 8, H AS 1263, I/A 46 (24.11.21).

22 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A45 (15.09.21).

18 de Agosto de 2021
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: DIAZ MARTINEZ ANDRES;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL.Presidente: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Secretario: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Nombramientos. Presidente:FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS. Secretario: GONZALEZ GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS1263, I/A 44 (10.08.21).

04 de Febrero de 2021
Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 42(27.01.21).

Nombramientos. Consejero: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 43(27.01.21).

18 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 41 (8.11.19).

24 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Vicepresid.: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS;PUJADES GONZALEZ JESUS;DIAZ MARTINEZ MARIACOVADONGA;GONZALEZ GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 40 (16.10.19).

11 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263,I/A 39 ( 2.10.19).

28 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 38(21.06.19).

17 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS1263, I/A 36 ( 4.12.18).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.165,20 Euros. Desembolsado: 27.165,20 Euros. Resultante Suscrito: 273.575,20 Euros.Resultante Desembolsado: 273.575,20 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datosregistrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 37 ( 4.12.18).

17 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 1065 , F 131, S8, H AS 1263, I/A 34 ( 7.09.18).

Revocaciones. Apoderado: SANZ CANGA JESUS HONORIO. Datos registrales. T 1065 , F 133, S 8, H AS 1263, I/A 35 ( 7.09.18).

03 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL. Presidente: ALVARGONZALEZ MARTINEZANTONIO MANUEL. Secretario: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Presidente: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Secretario:GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 33 (24.08.18).

29 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, HAS 1263, I/A 32 (19.12.17).

13 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR.Presidente: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS. Vicepresid.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Consejero:GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON;IBARZABALMENENDEZ IMELDA. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Secretario: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON.Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ ABARRIO JOSEMANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR;IBARZABAL MENENDEZIMELDA;ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Presidente: ALVARGONZALEZ MARTINEZANTONIO MANUEL. Vicepresid.: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Secretario: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Con.Delegado:ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 31 (30.11.16).

02 de Junio de 2016
Nombramientos. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS1263, I/A 30 (25.05.16).

25 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Consejero: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO.Nombramientos. Secretario: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 29(15.05.15).

21 de Enero de 2015
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, HAS 1263, I/A 28 (12.01.15).

19 de Septiembre de 2012
Modificaciones estatutarias. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.canteraslabelonga.es. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 27 ( 7.09.12).

10 de Abril de 2012
Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 130, S8, H AS 1263, I/A 25 (28.03.12).

26 de Octubre de 2011
Revocaciones. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Reelecciones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUISJUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO-MELCHOR. Presidente: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS.Vicepresid.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Secretario: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Consejero: VILLAVERDEBARCALA ROGELIO;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUANRAMON;IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Datos registrales. T 1065 , F 104, S 8, H AS 1263, I/A 24 (14.10.11).

Nombramientos. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 104, S 8, H AS 1263, I/A 25(14.10.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n