Actos BORME de Canteras La Belonga Sa
27 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, H AS 1263, I/A 53(16.03.23).
20 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: REGINSTER MAXIME;LOPEZ GUERRA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, HAS 1263, I/A 51 (13.02.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: REGINSTER MAXIME. Datos registrales. T 4510 , F 128, S 8, H AS 1263, I/A 52 (13.02.23).
10 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ IGLESIAS JUAN SATURNINO. Apo.Sol.: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUANJESUS;VILLAVERDE BARCALA ROGELIO;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Apoderado:FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: ARISTONDO SORALUCEGREGORIO. Apo.Manc.: DIAZ VILLA MANUEL;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Apoderado: IBARZABAL OSET JOSE LUIS.Nombramientos. Apo.Sol.: REGINSTER MAXIME. Apo.Manc.: REGINSTER MAXIME. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS1263, I/A 49 (30.09.22).
16 de Agosto de 2022Modificaciones estatutarias. 27. Organizaci贸n y de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS1263, I/A 48 ( 8.08.22).
10 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1065 , F 198, S 8, H AS 1263, I/A 47(30.11.21).
03 de Diciembre de 2021Nombramientos. Consejero: DIAZ MARTINEZ ANDRES;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 198,S 8, H AS 1263, I/A 46 (24.11.21).
22 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A45 (15.09.21).
18 de Agosto de 2021Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: DIAZ MARTINEZ ANDRES;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL.Presidente: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Secretario: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Nombramientos. Presidente:FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS. Secretario: GONZALEZ GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS1263, I/A 44 (10.08.21).
04 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: CENTIUM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 42(27.01.21).
Nombramientos. Consejero: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 43(27.01.21).
18 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 196, S 8, H AS 1263, I/A 41 (8.11.19).
24 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Vicepresid.: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ RAMIREZ MARIANO CARLOS;PUJADES GONZALEZ JESUS;DIAZ MARTINEZ MARIACOVADONGA;GONZALEZ GOMEZ MARIA. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 40 (16.10.19).
11 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263,I/A 39 ( 2.10.19).
28 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 38(21.06.19).
17 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS1263, I/A 36 ( 4.12.18).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.165,20 Euros. Desembolsado: 27.165,20 Euros. Resultante Suscrito: 273.575,20 Euros.Resultante Desembolsado: 273.575,20 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datosregistrales. T 1065 , F 195, S 8, H AS 1263, I/A 37 ( 4.12.18).
17 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 1065 , F 131, S8, H AS 1263, I/A 34 ( 7.09.18).
Revocaciones. Apoderado: SANZ CANGA JESUS HONORIO. Datos registrales. T 1065 , F 133, S 8, H AS 1263, I/A 35 ( 7.09.18).
03 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL. Presidente: ALVARGONZALEZ MARTINEZANTONIO MANUEL. Secretario: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Presidente: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Secretario:GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 33 (24.08.18).
29 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, HAS 1263, I/A 32 (19.12.17).
13 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR.Presidente: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS. Vicepresid.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Consejero:GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON;IBARZABALMENENDEZ IMELDA. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Secretario: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON.Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ ABARRIO JOSEMANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR;IBARZABAL MENENDEZIMELDA;ALVARGONZALEZ MARTINEZ ANTONIO MANUEL;DIAZ MARTINEZ ANDRES. Presidente: ALVARGONZALEZ MARTINEZANTONIO MANUEL. Vicepresid.: IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Secretario: DIAZ MARTINEZ ANDRES. Con.Delegado:ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 131, S 8, H AS 1263, I/A 31 (30.11.16).
02 de Junio de 2016Nombramientos. Con.Delegado: ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO MELCHOR. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS1263, I/A 30 (25.05.16).
25 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Consejero: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO.Nombramientos. Secretario: ARISTONDO MENENDEZ JUAN RAMON. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 29(15.05.15).
21 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, HAS 1263, I/A 28 (12.01.15).
19 de Septiembre de 2012Modificaciones estatutarias. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa:www.canteraslabelonga.es. Datos registrales. T 1065 , F 130, S 8, H AS 1263, I/A 27 ( 7.09.12).
10 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITA. Datos registrales. T 1065 , F 130, S8, H AS 1263, I/A 25 (28.03.12).
26 de Octubre de 2011Revocaciones. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Reelecciones. Consejero: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUISJUAN JESUS;ALVAREZ BENGOECHEA ARTURO-MELCHOR. Presidente: ALVARGONZALEZ ROMA脩A LUIS JUAN JESUS.Vicepresid.: GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL. Secretario: VILLAVERDE BARCALA ROGELIO. Consejero: VILLAVERDEBARCALA ROGELIO;GONZALEZ ABARRIO JOSE MANUEL;DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL;ARISTONDO MENENDEZ JUANRAMON;IBARZABAL MENENDEZ IMELDA. Datos registrales. T 1065 , F 104, S 8, H AS 1263, I/A 24 (14.10.11).
Nombramientos. Con.Delegado: DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 1065 , F 104, S 8, H AS 1263, I/A 25(14.10.11).