Actos BORME de Car Rentals Topco Sl
20 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DE KLERK PHILIP JOACHIM;SMITH GARY NEIL. Extinci贸n. Datos registrales. T 4460 , F211, S 8, H A 141568, I/A 33 ( 9.11.23).
06 de Febrero de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CAR RENTALS PARENTCO SA. CAR RENTALS SUBSIDIARY SA. Datosregistrales. T 4460 , F 210, S 8, H A 141568, I/A 32 (27.01.23).
23 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: KORVIN MARIE HELENE. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE KLERK PHILIP JOACHIM.Datos registrales. T 4460 , F 210, S 8, H A 141568, I/A 31 (16.11.22).
14 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ ALVAREZ JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Mancom.: SMITH GARY NEIL.Datos registrales. T 4460 , F 210, S 8, H A 141568, I/A 30 ( 6.06.22).
11 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: BERMEJO MARBAN GERARDO MIGUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: BAIXINHO DE CARVALHOHELDER CARLOS. Datos registrales. T 4356 , F 150, S 8, H A 141568, I/A 29 ( 1.04.22).
14 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PELIGRY LUC. Nombramientos. Adm. Mancom.: KORVIN MARIE HELENE. Datosregistrales. T 4356 , F 149, S 8, H A 141568, I/A 27 ( 3.03.22).
10 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Datos registrales. T 4356 , F 147, S 8, H A 141568,I/A 26 ( 2.03.22).
08 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: VILLAR TORRES JUAN FERNANDO. Apo.Sol.: PALAU LLOPIS ENRIQUE;BONET VALLS-TABERNERPEDRO;SAVAL SANCHIS JORGE. Nombramientos. Apoderado: EUROPCAR IB SA. Datos registrales. T 3864 , F 196, S 8, H A141568, I/A 25 (25.02.21).
02 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO GONZALEZ JOSE FRANCISCO;BERMEJO MARBAN GERARDO MIGUEL;VARONAGORDALIZA LAURA. Datos registrales. T 3864 , F 195, S 8, H A 141568, I/A 24 (25.08.20).
17 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Mancom.: GONZALEZALVAREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 3864 , F 195, S 8, H A 141568, I/A 23 ( 7.02.20).
20 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PEREZ CRUZ LUIS RAUL. Nombramientos. Adm. Mancom.: PELIGRY LUC. Datosregistrales. T 3864 , F 195, S 8, H A 141568, I/A 22 (12.02.19).
02 de Octubre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LC EC PARTICIPACIONS INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 3864 , F 195, S8, H A 141568, I/A 21 (25.09.18).
26 de Febrero de 2018Cambio de domicilio social. CTRA DE VALENCIA Km 115 - EDIFICIO GOLDCAR (SANT JOAN D'ALACANT). Datos registrales. T3864 , F 195, S 8, H A 141568, I/A 20 (16.02.18).
05 de Diciembre de 2017Revocaciones. CONSEJERO: BUSSARDI SARL. REPR.143 RRM: PANIKER ROMEU MATEO. CONSEJERO: MONROSE SARL.VICEPRESIDEN: MONROSE SARL. CONSEJERO: MI脩ANO SAN VALERO LUIS;EAST CONSULTING SERVICES SL.PRESIDENTE: EAST CONSULTING SERVICES SL. REPR.143 RRM: ALCARAZ ALCARAZ JUAN. V-SEC NO CON: RIPLEY SORIADANIEL IGNACIO. SECR.NO CONS: ALBI脩ANA CILVETI IGNACIO. VOCAL: VILLAR TORRES JUAN FERNANDO. REPR.143 RRM:ABDELKADER DERROUICHE. CONSEJERO: LEONARDO TRICARICO;AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS;VILLAR TORRESJUAN FERNANDO. CONS. DELEG.: AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS. CONSEJERO: PEREZ CRUZ LUIS RAUL;ESTRADAMAGGI FERNANDO;LAURENCE MARLOR. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS;PEREZCRUZ LLUIS. Otros conceptos: AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS SRES.AZCONA MARTINEZ YPEREZ CRUZ, PARA QUE PUEDAN DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL MISMO,ANALOGO O COMPLEMENARIOGENERO DE ACTIVIDAD QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 45095 , F 203, S 8, H B476664, I/A 20 (27.11.17).
08 de Agosto de 2016Nombramientos. CONSEJERO: ESTRADA MAGGI FERNANDO;LAURENCE MARLOR. Datos registrales. T 45095 , F 203, S 8, HB 476664, I/A 19 ( 1.08.16).
15 de Abril de 2016Revocaciones. CONSEJERO: CRUZ DE LLANO ALEJANDRO;PALAU LLOPIS ENRIQUE. Nombramientos. CONSEJERO: PEREZCRUZ LUIS RAUL. Datos registrales. T 45095 , F 203, S 8, H B 476664, I/A 18 ( 8.04.16).
15 de Diciembre de 2015Cambio de domicilio social. CL SELVA NUMERO 4 LOCAL A PLANTA 3 (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datos registrales. T45095 , F 202, S 8, H B 476664, I/A 17 ( 2.12.15).
13 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: REAL ROVIRA CATHERINA;BOUSSARD VIRGINIE;ESPI GISBERT MARIA LUISA. Nombramientos.Apo.Sol.: PALAU LLOPIS ENRIQUE;BONET VALLS-TABERNER PEDRO;SAVAL SANCHIS JORGE. Modificaci贸n de poderes.Apo.Sol.: ALBI脩ANA CILVETI IGNACIO;PEREZ RIVARES JUAN ANTONIO;GUASH SOL ARNAU;URREA TURNER CARLOS.Apo.Manc.: PALAU LLOPIS ENRIQUE;VILLAR TORRES JUAN FERNANDO. Datos registrales. T 3864 , F 194, S 8, H A 141568, I/A16 ( 5.11.15).
05 de Agosto de 2015Nombramientos. Con.Delegado: AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3864 , F 194, S 8, H A 141568, I/A 15(29.07.15).
17 de Junio de 2015Otros conceptos: Modificados la totalidad de los art铆culos de los Estatutos sociales.- Datos registrales. T 3830 , F 192, S 8, H A141568, I/A 14 (10.06.15).
26 de Marzo de 2015Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3830 , F 192, S 8, H A 141568, I/A 13 (17.03.15).
24 de Marzo de 2015Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3830 , F 191, S 8, H A 141568, I/A 12 (16.03.15).
23 de Marzo de 2015Nombramientos. Consejero: TRICARICO LEONARDO;AZCONA MARTINEZ JUAN CARLOS;PALAU LLOPIS ENRIQUE;VILLARTORRES JUAN FERNANDO. Datos registrales. T 3830 , F 191, S 8, H A 141568, I/A 11 (13.03.15).
20 de Marzo de 2015P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 3830 , F 191, S 8, H A 141568, I/A 10 (12.03.15).
18 de Marzo de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INTERNATIONAL CAR RENTALS II SCA. Datos registrales. T3830 , F 191, S 8, H A 141568, I/A 9 (11.03.15).
17 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: INTERNATIONAL CAR RENTALS SARL. Nombramientos. Consejero: BUSSARDISARL;MONROSE SARL;MI脩ANO SAN VALERO LUIS;CRUZ DE LLANO ALEJANDRO;EAST CONSULTING SERVICES SL.Presidente: EAST CONSULTING SERVICES SL. Vicepresid.: MONROSE SARL. SecreNoConsj: ALBI脩ANA CILVETI IGNACIO.VsecrNoConsj: RIPLEY SORIA DANIEL IGNACIO. Apo.Manc.: PALAU LLOPIS ENRIQUE;VILLAR TORRES JUAN FERNANDO.Apo.Sol.: ESPI GISBERT MARIA LUISA;ALBEROLA MARCO MARIA TERESA;PACHECO CASTELLANOS JUANANTONIO;MORENO MARTINEZ NURIA. Otros conceptos: Modificaci贸n de la totalidad de los art铆culos de los estatutos sociales.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 3830 , F 188, S 8, H A141568, I/A 8 (10.03.15).
06 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 3800 , F 183, S8, H A 141568, I/A 7 (30.01.15).
04 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 17.197.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.200.000,00 Euros. Cambio de domicilio social.CTRA DE VALENCIA Km 115 - EDIFICIO GOLDCAR (SANT JOAN D'ALACANT). Datos registrales. T 3800 , F 183, S 8, H A141568, I/A 6 (28.01.15).
08 de Enero de 2015Ampliacion del objeto social. La adquisici贸n, tenencia, enajenaci贸n, venta, alquiler, cesi贸n a terceros por cualquier t铆tulo yexplotaci贸n de toda clase de veh铆culos a motor, con o sin conductor. La reparaci贸n, mantenimiento, asistencia t茅cnica de todo tipo deveh铆culos a motor. La participaci贸n en otras sociedades de id茅ntico o. Datos registrales. T 3800 , F 183, S 8, H A 141568, I/A 5(30.12.14).