Actos BORME de Carbones Comercio Y Consignaciones Sa
15 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6715 , F 101, S 8, H SE 15752, I/A 76( 1.12.23).
25 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: LOZANO ROMERO AURORA;SANZ OLMEDO ANTONIO. Datos registrales. T 6715 , F 100, S 8, HSE 15752, I/A 74 (18.10.23).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ ROBERTO JOSE. Datos registrales. T 6715 , F 100, S 8, H SE 15752, I/A 75(18.10.23).
30 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: HERRERA MESIAS MARIA ANGELES;VIDAL DIAZ JUAN MANUEL;VIDAL DIAZ JUAN MANUEL.Apo.Sol.: DANA RODRIGUEZ FRANCISCO;DANA RODRIGUEZ FRANCISCO;DANA RODRIGUEZ FRANCISCO. Datos registrales.T 6715 , F 100, S 8, H SE 15752, I/A 73 (19.01.23).
24 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 6715 , F 100, S 8, H SE 15752,I/A 72 (15.12.21).
10 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6715 , F 99, S 8, H SE 15752, I/A 71(30.07.20).
23 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES. ARTICULO 8. Junta y 贸rgano de administraci贸n.ARTICULO 9. FORMA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y COMPOSICION DEL MISMO. . ARTICULO 11.- FORMA DE LACONVOCATORIA. . ARTICULO 18.- DURACION Y RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. ARTICULO 19BIS. DELFUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. . ARTICULO 22. ADJUDICACION "IN NATURA".. ARTICULO 23.-CONVENIO ARBITRAL.. ARTICULO 24.- DEL PROTOCOLO FAMILIAR.. Otros conceptos: Quedan RENUMERADOS TODOS LOSARTICULOS POSTERIORES AL NUMERO NUEVE de los estatutos de la sociedad de referencia Se crea el capitulo v de los estatutossociales que contiene el articulo 23; se crea asimismo el capitulo vi que contiene el articulo 24 de dicho estatutos sociales de lasociedad de referencia. Datos registrales. T 4862 , F 216, S 8, H SE 15752, I/A 69 (15.05.19).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: MAQUEDA LOPEZANTONIO. Consejero: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Presidente: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Con.Delegado: GONZALEZCARRION ROBERTO. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ ENGRACIA;GONZALEZ SANCHEZ ROBERTO JOSE;GONZALEZSANCHEZ BORJA;GONZALEZ SANCHEZ MARTA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 6715 , F 99, S 8, H SE 15752, I/A 70 (15.05.19).
25 de Octubre de 2017Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4862 , F 215, S 8, H SE 15752, I/A68 (16.10.17).
19 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DANA RODRIGUEZ FRANCISCO;AMUSCO GALVEZ JESUS;HERNANDEZ LOPEZ JOSELUIS;JIMENEZ FERNANDEZ LUCIA;GONZALEZ GARCIA AGUSTIN;MONGE DIAZ CRISTINA;MAQUEDA LOPEZ ANTONIO Datosregistrales. T 4862 , F 215, S 8, H SE 15752, I/A 66 (12.06.17).
Revocaciones. Apo.Sol.: GUZMAN PEREZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 4862 , F 215, S 8, H SE 15752, I/A 67(12.06.17).
29 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: MONGE DIAZ CRISTINA. Datos registrales. T 4862 , F 214, S 8, H SE 15752, I/A 65 (16.05.17).
23 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: NAVARRO HUERTA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4862 , F 214, S 8, H SE 15752, I/A 64(15.06.16).
09 de Junio de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: HERRERA MESIAS MARIA ANGELES. Datos registrales. T 4862 , F 214, S 8, H SE 15752, I/A 62(27.05.16).
Revocaciones. Apoderado: JUAN MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 4862 , F 214, S 8, H SE 15752, I/A 63 (27.05.16).
19 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4862 , F 213, S 8, H SE 15752, I/A 61(12.09.14).
17 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: MAQUEDA LOPEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4862 , F 213, S 8, H SE 15752, I/A 60 ( 9.06.14).
20 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ESCOBAR FRANCISCO JOSE;ALONSO ARENAS JOSE MARIA;RAMOS LEON JOSEMANUEL;MILLAN BERENGER VICENTE;ALONSO ARENAS JOSE MARIA;RAMOS LEON JOSE MANUEL;VIDAL DIAZMARCELINO;GONZALEZ CARRION ROBERTO;FERNANDEZ RIQUELME FRANCISCO;LARA GARCIA ANTONIO;MARTIN PEREZFAUSTINO. Apo.Sol.: SABATER PERALES JAIME;CALDERON MA脩E MILAGROS ROCIO;DO脩A MARTIN JAVIER. Apoderado:ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO. Datos registrales. T 4429 , F 212, S 8, H SE 15752, I/A 59 ( 5.08.13).
13 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Secretario: GONZALEZ SANCHEZ ROBERTO JOSE.Con.Delegado: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Consejero: GONZALEZ CARRION ROBERTO;GONZALEZ SANCHEZ ROBERTOJOSE;GONZALEZ SANCHEZ ENGRACIA;GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA;GONZALEZ SANCHEZ MARTA ROCIO.Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS TOTALMENTELOS ESTATUTOS SOCIALES Y REFUNDIDOS EN UN NUEVO TEXTO COMPRENSIVO DE LOS ARTICULOS 1潞 A 20潞, AMBOSINCLUSIVES, ELLO AL OBJETO DE ADAPTARLOS A LA VIGENTE LEYDE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL.- .Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de objeto social. Operaciones propias de OperadorLog铆stico, en particular; transporte, distribuci贸n, almacenaje y manipulaci贸n de mercanc铆as propias y ajenas.- Operaciones deTransitario; intermediaci贸n en transporte internacional.-Consignaciones de Buques y despachos de Aduana.- Tenencia yadministraci贸n de todo. Datos registrales. T 4429 , F 168, S 8, H SE 15752, I/A 58 (31.05.13).
29 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 4429 , F 168, S 8, H SE 15752, I/A 57
14 de Julio de 2011Nombramientos. Presidente: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Secretario: GONZALEZ SANCHEZ ROBERTO JOSE.Con.Delegado: GONZALEZ CARRION ROBERTO. Reelecciones. Consejero: GONZALEZ CARRION ROBERTO;GONZALEZSANCHEZ ROBERTO JOSE;GONZALEZ SANCHEZ ENGRACIA;GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA;GONZALEZSANCHEZ MARTA ROCIO. Datos registrales. T 4429 , F 167, S 8, H SE 15752, I/A 56 ( 4.07.11).
09 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: MAQUEDA LOPEZ ANTONIO. Datos registrales. T 4429 , F 167, S 8, H SE 15752, I/A 55 (30.08.10).
17 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ZAPATA MINGORANCE FRANCISCO IGNACIO. Datos registrales. T 4429 , F 166, S 8, H SE 15752,I/A 53 ( 8.03.10).
Nombramientos. Apoderado: JUAN MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 4429 , F 167, S 8, H SE 15752, I/A 54 ( 8.03.10).
11 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 3057 , F 118, S 8, H SE 15752,I/A 52 (22.12.09).
26 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SL. Datos registrales. T 3057 , F 118, S 8, H SE 15752, I/A 51(13.02.09).