Buscador CIF Logo

Actos BORME Carbonorte Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Carbonorte Sl

Actos BORME Carbonorte Sl - B79226056

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Carbonorte Sl con CIF B79226056

馃敊 Perfil de Carbonorte Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Carbonorte Sl

18 de Enero de 2021
Nombramientos. Apoderado: SOLLANO GAMBOA RODOLFO;DE LA CRUZ CARCEDO XABIER. Datos registrales. T 28557 , F23, S 8, H M 71384, I/A 55 (11.01.21).

26 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: PEREZ LAZA GABRIEL. Apo.Manc.: PEREZ LAZA GABRIEL. Apo.Man.Soli: PEREZ LAZA GABRIEL.Datos registrales. T 28557 , F 23, S 8, H M 71384, I/A 54 (19.10.20).

29 de Enero de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO;CABALLERO CARBONELL JOSE FRANCISCO. Datos

15 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: ESCAMEZ ESTEVEZ JACOBINA;LUENGO ZAMORANO JOSE VICENTE;FORNIELES RUEDA JOSEMANUEL;TOLEDO GARTEIZGOGEASCOA JORGE. Datos registrales. T 28557 , F 22, S 8, H M 71384, I/A 52 ( 8.11.19).

04 de Julio de 2019
Revocaciones. Apoderado: CARRE脩O MALLO CARMEN. Datos registrales. T 28557 , F 22, S 8, H M 71384, I/A 51 (27.06.19).

28 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MERLINO SANCHEZ-ELVIRA ROCIO. Datos registrales. T 28557 , F 21, S 8, H M 71384, I/A 50(20.11.18).

25 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: GIL ELEJOSTE EDUARDO. Nombramientos. Representan: REVUELTA GARCIA JOSE MARIA.Datos registrales. T 28557 , F 20, S 8, H M 71384, I/A 49 (18.04.17).

15 de Febrero de 2017
Otros conceptos: LA SOCIEDAD " AL AIR LIQUIDE ESPA脩A SA ", CON FECHA 30/05/2016, HA DESIGNADO A DO脩A TERESARASERO GUERRERO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE LA CITADA ENTIDAD EN EL CARGO DE ADMINISTRADORMANCOMUNADO QUE DESEMPE脩A EN " CARBONORTE SL " EN SUSTITUCION DE D. ANTONIO MARIA MELCHORSANTAOLALLA.- Datos registrales. T 28557 , F 20, S 8, H M 71384, I/A 48 ( 7.02.17).

31 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: MERLINO SANCHEZ-ELVIRA ROCIO. Datos registrales. T 28557 , F 19, S 8, H M 71384, I/A 47(23.01.17).

29 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: MELCHOR SANTAOLALLA ANTONIO MARIA. Nombramientos. Representan: RASEROGUERRERO TERESA. Datos registrales. T 28557 , F 19, S 8, H M 71384, I/A 45 (20.12.16).

Nombramientos. Apoderado: ESCAMEZ ESTEVEZ JACOBINA. Datos registrales. T 28557 , F 19, S 8, H M 71384, I/A 46(20.12.16).

05 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SOLLANO GAMBOA RODOLFO;PEREZ LAZA GABRIEL. Apo.Sol.: MERLINO SANCHEZ-ELVIRAROCIO. Datos registrales. T 28557 , F 18, S 8, H M 71384, I/A 44 (28.10.14).

09 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apoderado: RUIZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL;RUIZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL. Apo.Manc.: RUIZ FERNANDEZJOSE MIGUEL. Datos registrales. T 28557 , F 17, S 8, H M 71384, I/A 43 (30.09.14).

02 de Julio de 2014
Revocaciones. Apoderado: DEL PINO ALCAIDE JOSE LUIS. Datos registrales. T 28557 , F 17, S 8, H M 71384, I/A 42 (25.06.14).

18 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: LLOSENT DE NARDIZ MARIA DEL DULCE NOMBRE. Datos registrales. T 28557 , F 16, S 8, H M71384, I/A 40 ( 8.11.13).

Nombramientos. Apoderado: INSUELA LORENZO SANTIAGO;ZULOAGA TRINCADO I脩IGO;CACHO MONTESFERNANDO;IRIARTE DOMINGUEZ CLARA. Datos registrales. T 28557 , F 17, S 8, H M 71384, I/A 41 ( 8.11.13).

28 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: CARRE脩O MALLO CARMEN;PRADOS HIGUERAS MANUEL;CACHO MONTES FERNANDO;IRIARTEDOMINGUEZ CLARA. Datos registrales. T 28557 , F 15, S 8, H M 71384, I/A 39 (20.02.13).

17 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: IBARRA CORTADI ALFONSO. Datos registrales. T 28557 , F 15, S 8, H M 71384, I/A 38 (10.12.12).

24 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apoderado: OSADO ROBLEDO ADELAIDA;OSADO ROBLEDO ADELAIDA. Datos registrales. T 28557 , F 15, S 8,H M 71384, I/A 37 (10.08.12).

03 de Marzo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.099.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.004.542,00 Euros. Datos registrales. T 13806, F 225, S 8, H M 71384, I/A 36 (18.02.11).

24 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: MERLINO SANCHEZ ELVIRA ROCIO. Nombramientos. Apoderado: LLOSENT DE NARDIZ MARIADEL DULCE NOMBRE;OSADO ROBLEDO ADELAIDA;PRADOS HIGUERAS MANUEL. Datos registrales. T 13806 , F 224, S 8, H M71384, I/A 35 (13.01.11).

14 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: ETIENNE HUBERT. Nombramientos. Representan: MELCHOR SANTAOLALLA ANTONIOMARIA. Datos registrales. T 13806 , F 224, S 8, H M 71384, I/A 34 ( 1.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n