Actos BORME de Carburos Via Augusta Logistics Sociedad Limitada
16 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4604 , F 71, S 8, H Z 60552, I/A 29 ( 9.10.23).
27 de Marzo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ VALL FRANCESC JOSEP. Datos registrales. T 4604 , F 70, S 8, H Z 60552, I/A 28 (20.03.23).
08 de Febrero de 2023Otros conceptos: MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 4604 , F 68, S 8, H Z60552, I/A 27 (27.01.23).
26 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: NAVALLAS MOLINO JORGE. Apo.Sol.: VINARDELL CORONA SANDRA;VINARDELL CORONASANDRA. Datos registrales. T 4604 , F 67, S 8, H Z 60552, I/A 25 (18.10.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA BIEL VICTOR. Datos registrales. T 4604 , F 67, S 8, H Z 60552, I/A 26 (18.10.22).
18 de Agosto de 2022Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4604 , F 67, S 8, H Z 60552, I/A 24 (11.08.22).
20 de Julio de 2022Cambio de domicilio social. AUTO A-2 Km 328 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4273 , F 30, S 8, H Z 60552, I/A 22 (13.07.22).
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 3..- DURACION, COMIENZO DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOSOCIAL La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones en la fecha del otorgamiento de laescritura de constitución. El ejercicio social comenzará el 1 de Octubre de cada. Datos registrales. T 4604 , F 67, S 8, H Z 60552, I/A23 (13.07.22).
28 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SAYAS CARMELO ENRIQUE;PASCUAL LAPEÑA RAMON;PASCUAL LAPEÑA NURIA.Presidente: GONZALEZ SAYAS CARMELO ENRIQUE. Datos registrales. T 4232 , F 29, S 8, H Z 60552, I/A 18 (18.02.22).
Nombramientos. Presidente: TORRES BLANCH IGNACIO. Datos registrales. T 4232 , F 29, S 8, H Z 60552, I/A 19 (18.02.22).
Declaración de unipersonalidad. Socio único: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA. Datos registrales. T4232 , F 29, S 8, H Z 60552, I/A 20 (18.02.22).
15 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4232 , F 29, S 8, H Z 60552, I/A 17 ( 8.10.21).
13 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPE ALONSO MIQUEL. Nombramientos. Consejero: TORRES BLANCH IGNACIO. Datosregistrales. T 4232 , F 28, S 8, H Z 60552, I/A 16 ( 6.10.21).
17 de Agosto de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: DELAUME FABIEN BENOIT. Datos registrales. T 4232 , F 27, S 8, H Z 60552, I/A 14 (11.08.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MORA AMAIA. Datos registrales. T 4232 , F 28, S 8, H Z 60552, I/A 15 (11.08.21).
13 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4232 , F 27, S 8, H Z 60552, I/A 13 ( 5.10.20).
12 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VINARDELL CORONA SANDRA;GARCIA BIEL VICTOR. Datos registrales. T 4232 , F 27, S 8, H Z60552, I/A 12 ( 5.11.19).
07 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4232 , F 26, S 8, H Z 60552, I/A 10(29.10.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MORA AMAIA. Datos registrales. T 4232 , F 26, S 8, H Z 60552, I/A 11 (29.10.19).
10 de Agosto de 2017Nombramientos. Dir. General: CUCURELLA GAMISANS PERE. Apo.Man.Soli: CUCURELLA GAMISANS PERE. Datos registrales.T 4232 , F 24, S 8, H Z 60552, I/A 8 ( 2.08.17).
Ceses/Dimisiones. Dir. General: CORDERO MINGUELLA HECTOR. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORDERO MINGUELLAHECTOR. Datos registrales. T 4232 , F 26, S 8, H Z 60552, I/A 9 ( 2.08.17).
29 de Marzo de 2017Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 4232 , F 24, S 8, H Z 60552, I/A 7 (22.03.17).
08 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: VINARDELL CORONA SANDRA;GARCIA BIEL VICTOR. Datos registrales. T 4195 , F 16, S 8, H Z60552, I/A 4 (26.01.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE VASCONCELOS BORGES DE ARAUJO SONIA;ROBERTZ MARKUS;VIANA DIAS ANTONIOPEDRO;RUBIO APARICIO FRANCISCO JAVIER;CORDOBA RUIZ LAURA;HUELIN TRILLO JOSE ANTONIO;ALLUEVA GARZARANMANUEL. Datos registrales. T 4195 , F 17, S 8, H Z 60552, I/A 5 (26.01.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORDERO MINGUELLA HECTOR. Dir. General: CORDERO MINGUELLA HECTOR. Datosregistrales. T 4195 , F 17, S 8, H Z 60552, I/A 6 (26.01.17).
23 de Noviembre de 2016Ampliación de capital. Capital: 999.999,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.145.000,00 Euros. Datos registrales. T 4195 , F 16, S 8, HZ 60552, I/A 3 (14.11.16).