Buscador CIF Logo

Actos BORME Carcaba Madrid Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Carcaba Madrid Sl

Actos BORME Carcaba Madrid Sl - B28537611

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Carcaba Madrid Sl con CIF B28537611

🔙 Perfil de Carcaba Madrid Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Carcaba Madrid Sl

21 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL;NAVARRO NAVARRO MANUEL. Datos registrales. T 22082 , F98, S 8, H M 69382, I/A 23 (14.11.16).

29 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: CARCABA RODRIGUEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 22082 , F 98, S 8, H M 69382, I/A 21(20.06.16).

Nombramientos. Apoderado: CARCABA VALDES JOAQUIN. Datos registrales. T 22082 , F 98, S 8, H M 69382, I/A 22 (20.06.16).

23 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: TOME TOME JOSE MARIA. Datos registrales. T 22082 , F 97, S 8, H M 69382, I/A 20 (15.03.16).

18 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARCABA VALDES JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico: FIESTAS CARCABA SONIA. Datosregistrales. T 22082 , F 97, S 8, H M 69382, I/A 19 (11.01.16).

26 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: PEREZ MERE SAMUEL. Datos registrales. T 22082 , F 96, S 8, H M 69382, I/A 17 (17.06.14).

Nombramientos. Apoderado: ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22082 , F 97, S 8, H M 69382, I/A 18(17.06.14).

19 de Diciembre de 2013
Otros conceptos: REVOCADO PODER CONFERIDO A FAVOR DE D.EUGENIO CARCABA RODRIGUEZ MEDIANTE ESCRITURAAUTORIZADA POR EL NOTARIO DE MADRID D.RAMON FERNANDEZ PURON, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1983,PROTOCOLO 4549 QUE CAUSO LA INSCRIPCION 3&. Datos registrales. T 22082 , F 96, S 8, H M 69382, I/A 16 (12.12.13).

16 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: CARCABA RODRIGUEZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 22082 , F 96, S 8, H M 69382, I/A 15 (7.05.13).

03 de Septiembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: SANZ MOYA PEDRO;SANCHEZ SAINZ ISABEL;GARCIA FERNANDEZ EMMA;BARAGAÑAFERNANDEZ RODRIGO. Apo.Sol.: GARCIA FERNANDEZ EMMA;SANZ MOYA PEDRO;ADRADOS CUESTA MIGUELANGEL;SANCHEZ SAINZ ISABEL. Datos registrales. T 22082 , F 96, S 8, H M 69382, I/A 14 (17.08.12).

06 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS VALDES PILAR. Datos registrales. T 22082 , F 95, S 8, H M 69382, I/A 13 (26.07.12).

17 de Junio de 2011
Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 29 DE MARZO DE 2.011,POR EL NOTARIO DE OVIEDO, D.JOSE MARIA MOUTAS CIMADEVILLA,CON EL Nº 778, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 10&, EN EL SENTIDO DE HACERCONSTAR QUE EL NOMBRE Y APELLIDOS CORRECTOS DEL PRIMER APODERADO SON: DON MIGUEL ANGEL ADRADOSCUESTA. Datos registrales. T 22082 , F 95, S 8, H M 69382, I/A 12 ( 6.06.11).

28 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: ANDRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL;NAVARRO NAVARRO MANUEL;TOME TOME JOSE MARIA.Datos registrales. T 22082 , F 94, S 8, H M 69382, I/A 10 (15.04.11).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARCABA MARIA JOSE;GARCIA FERNANDEZ EMMA;NAVARRO NAVARROMANUEL;SANCHEZ SAINZ ISABEL;TOME TOME JOSE MARIA. Datos registrales. T 22082 , F 95, S 8, H M 69382, I/A 11(15.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información