Actos BORME de Carjimez Sociedad Anonima
30 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Liquidador M: MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO LUIS;JIMENEZ CARMONA MANUEL. Extinci贸n. Datosregistrales. T 1626 , F 172, S 8, H GR 1364, I/A 13 (23.11.17).
17 de Abril de 2017Nombramientos. Auditor: MU脩OZ CUESTA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 399 , F 182, S 8, H GR 1364, I/A 10 ( 6.04.17).
12 de Abril de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: JIMENEZ CARMONA MANUEL;JIMENEZ CARMONA ANTONIO;JIMENEZHOCES ANTONIO. Secretario: JIMENEZ CARMONA MANUEL. Cons.Del.Sol: JIMENEZ CARMONA MANUEL. Presidente: JIMENEZCARMONA ANTONIO. Cons.Del.Sol: JIMENEZ CARMONA ANTONIO. Datos registrales. T 399 , F 180, S 8, H GR 1364, I/AN.Mar(10.02.15).
22 de Enero de 2016Nombramientos. Consejero: JIMENEZ CARMONA MANUEL;FERNANDEZ NEGRI ANTONIA;JIMENEZ FERNANDEZ LUZ MARIA.Presidente: JIMENEZ CARMONA MANUEL. Secretario: JIMENEZ FERNANDEZ LUZ MARIA. Datos registrales. T 399 , F 181, S 8, HGR 1364, I/A 8 (15.01.16).
Nombramientos. Con.Delegado: JIMENEZ CARMONA MANUEL. Cambio de domicilio social. C/ PEDRO ANTONIO DEALARCON 31-BAJO - CON ENTRADA (GRANADA). Datos registrales. T 399 , F 181, S 8, H GR 1364, I/A 9 (15.01.16).
02 de Marzo de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 47.250,00 Euros. Desembolsado: 47.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.272.592,60 Euros.Resultante Desembolsado: 1.272.592,60 Euros. Datos registrales. T 399 , F 181, S 8, H GR 1364, I/A 7 (21.02.11).
11 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 755.000,00 Euros. Desembolsado: 755.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.225.342,60 Euros.Resultante Desembolsado: 1.225.342,60 Euros. Datos registrales. T 399 , F 180, S 8, H GR 1364, I/A 6 ( 2.03.10).