Actos BORME de Carnicas Frivall Sl
08 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL BURGOS ENRIQUE. Presidente: GIL BURGOS ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: GILVELAZQUEZ CRISTINA. Presidente: MORERA SERENTILL ALBERT. Cons.Del.Sol: GIL VELAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales.T 706 , F 108, S 8, H CU 4708, I/A 39 (26.04.23).
31 de Diciembre de 2020Revocaciones. Auditor: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SL. Nombramientos. Auditor: RSM SPAIN AUDITORESSLP. Datos registrales. T 706 , F 108, S 8, H CU 4708, I/A 38 (18.12.20).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: GARCIA DE LOS REYES JORGE. Datos registrales. T 706 , F 107, S 8, H CU 4708, I/A 37(18.07.19).
02 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 706 , F 106, S 8, H CU 4708, I/A 36(23.10.18).
13 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CHIA FORRADELLAS CARMINA. Datos registrales. T 706 , F 104, S 8, H CU 4708, I/A 35 ( 4.09.18).
27 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: GIL VELAZQUEZ CRISTINA. Apo.Man.Soli: PARRAGA MARTINEZ EMILIO. Apoderado: GILVELAZQUEZ CRISTINA;PARRAGA MARTINEZ EMILIO. Datos registrales. T 681 , F 107, S 8, H CU 4708, I/A 32 (17.10.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL VELAZQUEZ CRISTINA;GARCIA DE LOS REYES JORGE. Datos registrales. T 681 , F 107, S8, H CU 4708, I/A 33 (17.10.16).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA DE LOS REYES JORGE;GIL VELAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 706 , F 102, S 8,H CU 4708, I/A 34 (17.10.16).
16 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GIL BURGOS ENRIQUE. Revocaciones. Apoderado: MORERA SERENTILL ALBERT.Nombramientos. Cons.Del.Sol: MORERA SERENTILL ALBERT. Datos registrales. T 681 , F 101, S 8, H CU 4708, I/A 31 ( 6.06.16).
20 de Noviembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIL VELAZQUEZ CRISTINA;HORTELANO MARTINEZ JOSE DANIEL. Datos registrales. T 681 , F100, S 8, H CU 4708, I/A 29 (10.11.15).
Reelecciones. Auditor: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 681 , F 101, S 8, H CU 4708, I/A 30(11.11.15).
29 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: GIL VELAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 663 , F 203, S 8, H CU 4708, I/A 27 (21.07.15).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARRAGA MARTINEZ EMILIO. Apo.Manc.: GIL VELAZQUEZ CRISTINA. Datos registrales. T 681 ,F 97, S 8, H CU 4708, I/A 28 (21.07.15).
24 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL VELAZQUEZ CRISTINA;HORTELANO MARTINEZ JOSE DANIEL. Datos registrales. T 610 , F186, S 8, H CU 4708, I/A 26 (15.07.14).
21 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL VELAZQUEZ CRISTINA;HORTELANO MARTINEZ JOSE DANIEL. Datos registrales. T 610 , F183, S 8, H CU 4708, I/A 25 (13.02.13).
29 de Octubre de 2012Nombramientos. Auditor: IMAFIEL AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 610 , F 182, S 8, H CU 4708, I/A 24(16.10.12).
28 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTINEZ MIGUEL. Con.Delegado: GARCIA MARTINEZ MIGUEL. Presidente: GARCIAMARTINEZ MIGUEL. Nombramientos. Presidente: GIL BURGOS ENRIQUE. Cons.Del.Sol: GIL BURGOS ENRIQUE. Datosregistrales. T 581 , F 219, S 8, H CU 4708, I/A 23 (19.12.11).
18 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MORERA SERENTILL ALBERT. Nombramientos. Apoderado: MORERA SERENTILL ALBERT.Datos registrales. T 581 , F 216, S 8, H CU 4708, I/A 22 ( 4.10.11).
19 de Octubre de 2010Nombramientos. Consejero: MORERA SERENTILL ALBERT. Cons.Del.Sol: MORERA SERENTILL ALBERT. Datos registrales. T524 , F 90, S 8, H CU 4708, I/A 21 ( 5.10.10).
07 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 524 , F 89, S 8, H CU 4708, I/A20 (26.11.09).