Actos BORME de Caro Ruiz Sa
31 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 23.100,00 Euros. Desembolsado: 23.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 273.100,00 Euros.Resultante Desembolsado: 273.100,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ALIMENTACION GUADALGENIL SL.Datos registrales. T 2701 , F 205, S 8, H CO 896, I/A 58 (24.01.23).
10 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: TOMAS ESPONERA DIEGO. Datos registrales. T 2701 , F 204, S 8, H CO 896, I/A 56 ( 1.12.21).
15 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2701 , F 203, S 8, H CO 896, I/A 55 ( 8.10.21).
18 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2701 , F 202, S 8, H CO 896, I/A 53 (11.11.20).
09 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Vicepresid.: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Nombramientos.Consejero: AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL. Vicepresid.: AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL.Reelecciones. Consejero: HD COVALCO SL. Presidente: HD COVALCO SL. Consejero: JUCALARA SL;SAPERAS VERGARAJORDI. Secretario: SAPERAS VERGARA JORDI. Con.Delegado: HD COVALCO SL. Consejero: PALM RIO INVESTMENTS SL.Datos registrales. T 2701 , F 202, S 8, H CO 896, I/A 52 ( 2.07.20).
29 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLO LARA JUAN. Datosregistrales. T 2701 , F 201, S 8, H CO 896, I/A 51 (17.04.20).
14 de Abril de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ RUIZ RAFAEL. Datos registrales. T 1313 , F 35, S 8, H CO 896, I/A 49 ( 1.04.20).
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO LARA JUAN. Datos registrales. T 2701 , F 200, S 8, H CO 896, I/A 50 ( 2.04.20).
26 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: CASTILLO LARA JUAN. Datos registrales. T 1313 , F 35, S 8, H CO 896, I/A 48 (18.03.20).
23 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 34, S 8, H CO 896, I/A 47 (16.01.20).
28 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 34, S 8, H CO 896, I/A 46 (21.01.19).
22 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 33, S 8, H CO 896, I/A 43 (15.05.18).
11 de Agosto de 2016Revocaciones. Apo.Manc.: CARO GONZALEZ SARA. Datos registrales. T 1313 , F 33, S 8, H CO 896, I/A 42 ( 4.08.16).
20 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SAPERAS VERGARA JORDI. Datos registrales. T 1313 , F 31, S 8, H CO 896, I/A 41 (12.05.16).
21 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA;ARIZA DELGADO MANUEL DAVID. Apo.Manc.: VIVES PLANELLJOAN. Datos registrales. T 1313 , F 30, S 8, H CO 896, I/A 39 (13.04.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAPUENTE GINE DAVID. Apo.Manc.: SAPERAS AYMAR JOSEP;CASTELLS GARCIAMIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datos registrales. T 1313 , F 30, S 8, H CO 896, I/A 40 (13.04.16).
05 de Enero de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAPERAS AYMAR JOSEP. Apo.Manc.: CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN.Datos registrales. T 1313 , F 29, S 8, H CO 896, I/A 38 (28.12.15).
29 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: BENITEZ PUNZANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1306 , F 93, S 8, H CO 896, I/A 37(22.05.15).
24 de Octubre de 2014Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1306 , F 93, S 8, H CO 896, I/A 36 (16.10.14).
08 de Octubre de 2014Modificaciones estatutarias. 4. Domicilio.-. 7. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. 20.Otros.-. Art铆culo de los estatutos: 15. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 1306 , F 91, S 8, H CO 896, I/A 35 ( 1.10.14).
17 de Septiembre de 2014Nombramientos. Consejero: PALM RIO INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 1305 , F 187, S 8, H CO 896, I/A 31 (14.08.14).
10 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datos registrales. T 1306 , F 91, S 8, H CO 896, I/A 34 (28.08.14).
04 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: VIVES PLANELL JOAN;CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datosregistrales. T 1306 , F 89, S 8, H CO 896, I/A 32 (28.08.14).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLO LARA JUAN. Apo.Manc.: CARO GONZALEZ SARA;FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA.Datos registrales. T 1306 , F 90, S 8, H CO 896, I/A 33 (28.08.14).
22 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARO GONZALEZ SARA. Nombramientos. Consejero: HD COVALCO SL. Presidente: HDCOVALCO SL. Consejero: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Vicepresid.: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Consejero: JUCALARASL;SAPERAS VERGARA JORDI. Secretario: SAPERAS VERGARA JORDI. Cons.Del.Sol: HD COVALCO SL;CENTRO COMERCIALCARO SL;JUCALARA SL;SAPERAS VERGARA JORDI. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 12. Administraci贸n yRepresentacion.-. Art铆culo de los estatutos: 14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 1305 , F 187, S 8, H CO 896,I/A 31 (14.08.14).
13 de Marzo de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 30 ( 5.03.14).
15 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 29 ( 8.01.13).
22 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Nombramientos. Adm. Unico: CARO GONZALEZ SARA.Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 28 (14.06.12).
28 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 27 (20.12.11).
02 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 26 (24.11.10).
08 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 25 (29.09.09).
13 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: TAPIADOR MARTINEZ MARIA ENRIQUETA. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 24( 4.05.09).
04 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Presidente: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Cons.Del.Sol:CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Consejero: CARO GONZALEZ SARA. Secretario: CARO GONZALEZ SARA. Cons.Del.Sol: CAROGONZALEZ SARA. Consejero: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Vicepresid.: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Vicesecret.:CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Cons.Del.Sol: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Nombramientos. Adm. Unico: CAROGONZALEZ ALICIA BELEN. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 12. Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culode los estatutos: 14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 1305 , F 184, S 8, H CO 896, I/A 23 (26.01.09).