Buscador CIF Logo

Actos BORME Caro Ruiz Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Caro Ruiz Sa

Actos BORME Caro Ruiz Sa - A14030027

Tenemos registrados 33 Actos BORME del Registro Mercantil de Cordoba para Caro Ruiz Sa con CIF A14030027

馃敊 Perfil de Caro Ruiz Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cordoba

Actos BORME de Caro Ruiz Sa

31 de Enero de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 23.100,00 Euros. Desembolsado: 23.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 273.100,00 Euros.Resultante Desembolsado: 273.100,00 Euros. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ALIMENTACION GUADALGENIL SL.Datos registrales. T 2701 , F 205, S 8, H CO 896, I/A 58 (24.01.23).

10 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: TOMAS ESPONERA DIEGO. Datos registrales. T 2701 , F 204, S 8, H CO 896, I/A 56 ( 1.12.21).

15 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2701 , F 203, S 8, H CO 896, I/A 55 ( 8.10.21).

18 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2701 , F 202, S 8, H CO 896, I/A 53 (11.11.20).

09 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Vicepresid.: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Nombramientos.Consejero: AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL. Vicepresid.: AGEMOSA DE NEGOCIOS E INVERSIONES SL.Reelecciones. Consejero: HD COVALCO SL. Presidente: HD COVALCO SL. Consejero: JUCALARA SL;SAPERAS VERGARAJORDI. Secretario: SAPERAS VERGARA JORDI. Con.Delegado: HD COVALCO SL. Consejero: PALM RIO INVESTMENTS SL.Datos registrales. T 2701 , F 202, S 8, H CO 896, I/A 52 ( 2.07.20).

29 de Abril de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLO LARA JUAN. Datosregistrales. T 2701 , F 201, S 8, H CO 896, I/A 51 (17.04.20).

14 de Abril de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ RUIZ RAFAEL. Datos registrales. T 1313 , F 35, S 8, H CO 896, I/A 49 ( 1.04.20).

Nombramientos. Apoderado: CASTILLO LARA JUAN. Datos registrales. T 2701 , F 200, S 8, H CO 896, I/A 50 ( 2.04.20).

26 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO LARA JUAN. Datos registrales. T 1313 , F 35, S 8, H CO 896, I/A 48 (18.03.20).

23 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 34, S 8, H CO 896, I/A 47 (16.01.20).

28 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 34, S 8, H CO 896, I/A 46 (21.01.19).

22 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1313 , F 33, S 8, H CO 896, I/A 43 (15.05.18).

11 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: CARO GONZALEZ SARA. Datos registrales. T 1313 , F 33, S 8, H CO 896, I/A 42 ( 4.08.16).

20 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apoderado: SAPERAS VERGARA JORDI. Datos registrales. T 1313 , F 31, S 8, H CO 896, I/A 41 (12.05.16).

21 de Abril de 2016
Revocaciones. Apoderado: FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA;ARIZA DELGADO MANUEL DAVID. Apo.Manc.: VIVES PLANELLJOAN. Datos registrales. T 1313 , F 30, S 8, H CO 896, I/A 39 (13.04.16).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LAPUENTE GINE DAVID. Apo.Manc.: SAPERAS AYMAR JOSEP;CASTELLS GARCIAMIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datos registrales. T 1313 , F 30, S 8, H CO 896, I/A 40 (13.04.16).

05 de Enero de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAPERAS AYMAR JOSEP. Apo.Manc.: CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN.Datos registrales. T 1313 , F 29, S 8, H CO 896, I/A 38 (28.12.15).

29 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: BENITEZ PUNZANO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1306 , F 93, S 8, H CO 896, I/A 37(22.05.15).

24 de Octubre de 2014
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 1306 , F 93, S 8, H CO 896, I/A 36 (16.10.14).

08 de Octubre de 2014
Modificaciones estatutarias. 4. Domicilio.-. 7. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. 20.Otros.-. Art铆culo de los estatutos: 15. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 1306 , F 91, S 8, H CO 896, I/A 35 ( 1.10.14).

17 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Consejero: PALM RIO INVESTMENTS SL. Datos registrales. T 1305 , F 187, S 8, H CO 896, I/A 31 (14.08.14).

10 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datos registrales. T 1306 , F 91, S 8, H CO 896, I/A 34 (28.08.14).

04 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: VIVES PLANELL JOAN;CASTELLS GARCIA MIGUEL;TORDERA ARAUS JOAQUIN. Datosregistrales. T 1306 , F 89, S 8, H CO 896, I/A 32 (28.08.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLO LARA JUAN. Apo.Manc.: CARO GONZALEZ SARA;FUILLERAT GONZALEZ SETEFILLA.Datos registrales. T 1306 , F 90, S 8, H CO 896, I/A 33 (28.08.14).

22 de Agosto de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARO GONZALEZ SARA. Nombramientos. Consejero: HD COVALCO SL. Presidente: HDCOVALCO SL. Consejero: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Vicepresid.: CENTRO COMERCIAL CARO SL. Consejero: JUCALARASL;SAPERAS VERGARA JORDI. Secretario: SAPERAS VERGARA JORDI. Cons.Del.Sol: HD COVALCO SL;CENTRO COMERCIALCARO SL;JUCALARA SL;SAPERAS VERGARA JORDI. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 12. Administraci贸n yRepresentacion.-. Art铆culo de los estatutos: 14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 1305 , F 187, S 8, H CO 896,I/A 31 (14.08.14).

13 de Marzo de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 30 ( 5.03.14).

15 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 29 ( 8.01.13).

22 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Nombramientos. Adm. Unico: CARO GONZALEZ SARA.Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 28 (14.06.12).

28 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 186, S 8, H CO 896, I/A 27 (20.12.11).

02 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 26 (24.11.10).

08 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 25 (29.09.09).

13 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: TAPIADOR MARTINEZ MARIA ENRIQUETA. Datos registrales. T 1305 , F 185, S 8, H CO 896, I/A 24( 4.05.09).

04 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Presidente: CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Cons.Del.Sol:CARO GONZALEZ ALICIA BELEN. Consejero: CARO GONZALEZ SARA. Secretario: CARO GONZALEZ SARA. Cons.Del.Sol: CAROGONZALEZ SARA. Consejero: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Vicepresid.: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Vicesecret.:CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Cons.Del.Sol: CARO GONZALEZ MONTSERRAT. Nombramientos. Adm. Unico: CAROGONZALEZ ALICIA BELEN. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 12. Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culode los estatutos: 14. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 1305 , F 184, S 8, H CO 896, I/A 23 (26.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n