Actos BORME de Caroll Iberia Sl
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42285 , F 65, S 8, H M 292442, I/A 32 (27.10.23).
04 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: ALIAGA SAEZ ICIAR. Datos registrales. T 42285 , F 65, S 8, H M 292442, I/A 31 (28.03.23).
11 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42285 , F 65, S 8, H M 292442, I/A 30 ( 4.10.22).
03 de Junio de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42285 , F 65, S 8, H M 292442, I/A 29 (27.05.22).
15 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 21. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 42285 , F 64, S 8, H M292442, I/A 28 ( 8.03.22).
09 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LILIENFELD SANDRINE. Nombramientos. Adm. Unico: JEROME STANISLAS ALEXANDREDRIANNO. Datos registrales. T 42285 , F 60, S 8, H M 292442, I/A 25 (30.11.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LEVY KARINE. Apoderado: DORRONSORO DORRONSORO JUAN MIGUEL;RAZQUIN ORBEGOZORAFAEL;LEUNDA DE SOUZA AITOR;MEDAOURI DELPHINE;LECREST CHRISTOPHE. Apo.Man.Soli: CORNILLE ARMELLE MARIEEDMEE ISABELLE. Apoderado: DORRONSORO DORRONSORO JUAN MIGUEL;LEUNDA DE SOSA AITOR;DORRONSORODORRONSORO JUAN MIGUEL;GARRIGA CHABERT DAVID;LEUNDA DE SOSA AITOR;ISASA SARRALDE IÑIGO;ROMANOSANCHEZ SARA. Apo.Manc.: PUY PATRICK;LOUIS THIERRY. Apo.Sol.: ALIAGA SAEZ ICIAR. Nombramientos. Apoderado:MUNMANY VARELA MUNMANY CRISTINA;ESTEVA ALSINA MIQUEL. Datos registrales. T 42285 , F 60, S 8, H M 292442, I/A 26(30.11.21).
Nombramientos. Apoderado: BAUS HELENE SANDRA NATHALIE;CERDEÑO VIDAL NATACHA;LUCAS MARTIN ELISA PILAR.Datos registrales. T 42285 , F 64, S 8, H M 292442, I/A 27 (30.11.21).
26 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17083 , F 225, S 8, H M 292442, I/A 24 (19.10.21).
21 de Enero de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CAROLL INTERNATIONAL SA. Datos registrales. T 17083 , F 225,S 8, H M 292442, I/A 23 (14.01.21).
23 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17083 , F 225, S 8, H M 292442, I/A 22 (16.07.20).
13 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: CRESPO FESSART ALBANE. Datos registrales. T 17083 , F 224, S 8, H M 292442, I/A 21 ( 5.09.18).
16 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO FESSART ALBANE. Apo.Manc.: PUY PATRICK;LOUIS THIERRY;LEBHAR FEDERIC.Apo.Sol.: ALIAGA SAEZ ICIAR. Apo.Manc.: LOPES SANDRA. Datos registrales. T 17083 , F 223, S 8, H M 292442, I/A 20 ( 9.04.18).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: XERCAVINS LLUCH VICTOR;GANDOY FERNANDEZ ISABEL;GALLEGO FRIAS JAVIER;CHENGZHANG WENWEN;MONT CASTRO LAURA. Datos registrales. T 17083 , F 222, S 8, H M 292442, I/A 19 ( 9.03.18).
15 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 93 2 - OFICINA 222 (MADRID). Datos registrales. T 17083 , F 222, S 8,H M 292442, I/A 18 ( 8.03.18).
01 de Septiembre de 2017Nombramientos. AUDIT.INDIV.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41250 , F 74, S 8, H B 378651, I/A 32 (24.08.17).
12 de Mayo de 2017Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: VIVARTE MANAGEMENT SERVICES S.A.S.Datos registrales. T 41250 , F 73, S 8, H B 378651, I/A 31 ( 3.05.17).
19 de Abril de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: MARTINE BARRACHINA. Nombramientos. ADM.UNICO: SANDRINE LILIENFELD. Datosregistrales. T 41250 , F 73, S 8, H B 378651, I/A 30 (10.04.17).
10 de Noviembre de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: RICHARD SIMONIN. Nombramientos. ADM.UNICO: MARTINE BARRACHINA. Datos registrales. T41250 , F 73, S 8, H B 378651, I/A 29 (29.10.15).
03 de Septiembre de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: THIERRY JAUGEAS. Nombramientos. ADM.UNICO: RICHARD SIMONIN. Datos registrales. T41250 , F 73, S 8, H B 378651, I/A 28 (27.08.15).
31 de Julio de 2015Nombramientos. APOD.MANCOMU: ROMANO SANCHEZ SARA. Datos registrales. T 41250 , F 72, S 8, H B 378651, I/A 27(23.07.15).
04 de Mayo de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: JOSE ANTOINE APARISI. Nombramientos. ADM.UNICO: THIERRY JAUGEAS. Datos registrales.T 41250 , F 72, S 8, H B 378651, I/A 26 (24.04.15).
13 de Noviembre de 2014Revocaciones. APODERADO: SYLVIE COLIN. Datos registrales. T 41250 , F 71, S 8, H B 378651, I/A 24 ( 4.11.14).
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ISASA SARRALDE IÑIGO. Datos registrales. T 41250 , F 71, S 8, H B 378651, I/A 25 (4.11.14).
26 de Marzo de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: SYLVIE COLIN. Nombramientos. ADM.UNICO: JOSE ANTOINE APARISI. Datos registrales. T41250 , F 71, S 8, H B 378651, I/A 23 (19.03.14).
31 de Diciembre de 2012Revocaciones. APODERADO: ORTIZ GONZALEZ MARTA;ESTHER ADROHER;MARIE ABOS;BENOIT BARRIERE;RAZQUIMORBEGOZO RAFAEL. Datos registrales. T 41250 , F 71, S 8, H B 378651, I/A 22 (20.12.12).
12 de Abril de 2012Nombramientos. APODERADO: LEUNDA DE SOSA AITOR;DORRONSORO DORRONSORO JUAN MIGUEL;GARRIGA CHABERTDAVID. Datos registrales. T 41250 , F 69, S 8, H B 378651, I/A 18 (29.03.12).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41250 , F 69, S 8, H B 378651, I/A 19 (29.03.12).
Revocaciones. ADM.UNICO: RAYMOND ALAIN COTTET. Nombramientos. ADM.UNICO: SYLVIE COLIN. Datos registrales. T41250 , F 70, S 8, H B 378651, I/A 20 (29.03.12).
Nombramientos. APODERADO: LEUNDA DE SOSA AITOR;DORRONSORO DORRONSORO JUAN MIGUEL. Datos registrales. T41250 , F 70, S 8, H B 378651, I/A 21 (29.03.12).
10 de Junio de 2009Cambio de domicilio social. CL PAU CLARIS Num.132 P.5 (BARCELONA). Datos registrales. T 41250 , F 69, S 8, H B 378651, I/A17 (27.05.09).
03 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: FOURAY VERONIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORNILLE ARMELLE MARIE EDMEEISABELLE. Datos registrales. T 17083 , F 215, S 8, H M 292442, I/A 16 (24.03.09).