Actos BORME de Cartera De Inversiones Agroalimentarias Sociedad Limitada
25 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ RUBIO MANUEL;FERNANDEZ MU脩OZ MIGUEL ANGEL. Presidente: FERNANDEZ MU脩OZMIGUEL ANGEL. Consejero: MARTINEZ MADRID ANGEL ELOY. Secretario: MARTINEZ MADRID ANGEL ELOY. Con.Delegado:DIAZ RUBIO MANUEL. Nombramientos. Liquidador: DIAZ RUBIO MANUEL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 510 , F 10, S 8, H J 16332, I/A 14 (17.01.18).
23 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MORENO RODRIGO. SecreNoConsj: GARCIA OJEDA LOMBARGO JUAN CARLOS.Cons.Del.Man: LOPEZ MORENO RODRIGO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MADRID ANGEL ELOY. Secretario:MARTINEZ MADRID ANGEL ELOY. Con.Delegado: DIAZ RUBIO MANUEL. Datos registrales. T 510 , F 10, S 8, H J 16332, I/A 13(15.02.17).
29 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE. Presidente: GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE.Cons.Del.Man: GUTIERREZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ MU脩OZ MIGUEL ANGEL.Presidente: FERNANDEZ MU脩OZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 510 , F 9, S 8, H J 16332, I/A 11 (22.02.16).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: UNICAJA BANCO SAU. Datos registrales. T 510 , F 10, S 8, H J 16332, I/A 12(22.02.16).
18 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN PADILLA DIONISIO. Cons.Del.Man: MARTIN PADILLA DIONISIO. Nombramientos.Consejero: DIAZ RUBIO MANUEL. Cambio de objeto social. a) La prestacl6n de servicios de asesoramiento, asistencia t茅cnicarelacionados con la administraci贸n de sociedades participadas, con su estructura financiera o con sus procesos productivos o decomercializaci贸n.- c) La elaboraci贸n, distribuci贸n y comercializaci贸n de todo tipo de aceites vegetales. Datos registrales. T 510 , F 9,S 8, H J 16332, I/A 10 (11.09.13).
20 de Febrero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Datos registrales. T 510 , F9, S 8, H J 16332, I/A 9 (13.02.13).
11 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: RUIZ DE AREVALO ARROYO PABLO. Consejero: LINARES TORRES LUIS FERNANDO;DIAZRUBIO MANUEL;DELGADO EXPOSITO FACUNDO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA OJEDA LOMBARGO JUANCARLOS. Datos registrales. T 425 , F 76, S 8, H J 16332, I/A 8 ( 3.10.12).
06 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Presidente: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA.Cons.Del.Man: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Consejero: SANCHEZ BARANDA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 425 , F76, S 8, H J 16332, I/A 7 (23.05.12).
23 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: LINARES TORRES LUIS FERNANDO. Reelecciones. Cons.Del.Man: YEREGUI KINKEL MARIAEUGENIA;LOPEZ MORENO RODRIGO. Datos registrales. T 425 , F 76, S 8, H J 16332, I/A 6 (11.05.12).
14 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: RUIZ DE AREVALO ARROYO PABLO. Consejero: RUIZ DE AREVALO ARROYO PABLO.Nombramientos. Consejero: DELGADO EXPOSITO FACUNDO. Secretario: RUIZ DE AREVALO ARROYO PABLO. Datosregistrales. T 425 , F 74, S 8, H J 16332, I/A 4 ( 6.07.10).
14 de Agosto de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 425 , F 74, S 8, HJ 16332, I/A 2 ( 5.08.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASADO LOMAS JOSE. Presidente: LINARES TORRES LUIS FERNANDO. SecreNoConsj:SANCHEZ MAILLO MANUEL. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ BARANDA JOSE IGNACIO;DIAZ RUBIO MANUEL;RUIZ DEAREVALO ARROYO PABLO. Presidente: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Secretario: RUIZ DE AREVALO ARROYO PABLO.Cons.Del.Man: YEREGUI KINKEL MARIA EUGENIA. Reelecciones. Cons.Del.Man: LINARES TORRES LUIS FERNANDO;LOPEZMORENO RODRIGO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datosregistrales. T 425 , F 74, S 8, H J 16332, I/A 3 ( 5.08.09).