Actos BORME de Cartera De Valores Iasa Sl
01 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ-VALDES FLOREZ-DE QUI脩ONES I脩IGO. Datos registrales. T 35137 , F 169, S 8, H M260766, I/A 26 (24.11.23).
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ-VALDES FLOREZ DE QUI脩ONES I脩IGO. Datos registrales. T 35137 , F 170, S 8, H M260766, I/A 27 (24.11.23).
14 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LLANO OSCAR;FERNANDEZ DE LLANO OSCAR. Datos registrales. T 35137 , F
05 de Octubre de 2022Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35137 , F 168, S 8, H M 260766, I/A 24 (28.09.22).
29 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ VALDES FLOREZ DE QUI脩ONES I脩IGO. Datos registrales. T 35137 , F 168, S 8, H M260766, I/A 23 (22.03.22).
08 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35137 , F 167, S 8, H M 260766, I/A 22 ( 1.10.21).
11 de Mayo de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.271,00 Euros. Resultante Suscrito: 38.729,00 Euros. Datos registrales. T 35137 , F166, S 8, H M 260766, I/A 21 ( 4.05.21).
10 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: GUIL NAVARRO MARIA JOSEFA. Datos registrales. T 35137 , F 165, S 8, H M 260766, I/A 19 (1.12.20).
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ-VALDES FLOREZ DE QUI脩ONES I脩IGO. Datos registrales. T 35137 , F 166, S 8, H M260766, I/A 20 ( 1.12.20).
26 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: DIAZ YEREGUI RAFAEL. Consejero: ALVAREZ GUIL MARTA FRANCISCA;ALVAREZ GUILCRISTINA CONSUELO. Presidente: ALVAREZ GUIL CRISTINA CONSUELO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ GUIL CRISTINACONSUELO;ALVAREZ GUIL MARTA FRANCISCA. Nombramientos. Adm. Unico: ARIAS RIVAS FERNANDO. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 35137 , F 165, S 8, HM 260766, I/A 18 (19.03.20).
06 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: HERNANDEZ GIL ALVAREZ CIENFUEGOS ANTONIO. Secretario: HERNANDEZ GIL ALVAREZCIENFUEGOS ANTONIO. Nombramientos. Secretario: DIAZ YEREGUI RAFAEL. Datos registrales. T 35137 , F 165, S 8, H M260766, I/A 17 (28.02.20).
29 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DE LLANO OSCAR. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LLANO OSCAR.Datos registrales. T 35137 , F 164, S 8, H M 260766, I/A 16 (22.11.19).
28 de Diciembre de 2018Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35137 , F 163, S 8, H M 260766, I/A 15 (19.12.18).
14 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GUIL NAVARRO MARIA JOSEFA. Datos registrales. T 35137 , F 162, S 8, H M 260766, I/A 13 (7.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LLANO OSCAR. Datos registrales. T 35137 , F 163, S 8, H M 260766, I/A 14 (7.06.17).
22 de Noviembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 121.450.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 50.000,00 Euros. Datos registrales. T 15507 ,F 190, S 8, H M 260766, I/A 12 (15.11.16).
13 de Enero de 2016Modificaciones estatutarias. 26. Cierre del Ejercicio.- Cambio del cierre del ejercicio social.. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10.
31 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Cons.Del.Sol: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMOCARLOS. Presidente: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Nombramientos. Presidente: ALVAREZ GUIL CRISTINACONSUELO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ GUIL CRISTINA CONSUELO;ALVAREZ GUIL MARTA FRANCISCA. Datos registrales. T15507 , F 190, S 8, H M 260766, I/A 10 (23.07.15).
15 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO. Presidente: ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO. Cons.Del.Sol: ALVAREZ
16 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Nombramientos. Secretario: HERNANDEZ GILALVAREZ CIENFUEGOS ANTONIO. Consejero: ALVAREZ GUIL MARTA FRANCISCA;ALVAREZ GUIL CRISTINA CONSUELO.Datos registrales. T 15507 , F 189, S 8, H M 260766, I/A 8 ( 8.09.14).
31 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LLANO OSCAR. Datos registrales. T 15507 , F 189, S 8, H M 260766, I/A 7(20.03.14).