Actos BORME de Casa Botas Viuda De J Martinez Blasco Sl
22 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: REY FIGUEROA FRANCISCO. Datos registrales. T 4320, L 4320, F 220, S 8, H PO 4786, I/A 35(10.11.23).
20 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ VARELA ANGEL;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;FERNANDEZ RIVEIROLUIS;MOSQUERA RUIZ ADRIAN;MOSQUERA RUIZ DAVID. Datos registrales. T 4320, L 4320, F 220, S 8, H PO 4786, I/A 34(12.04.21).
26 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS. Apo.Manc.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS. Apo.Sol.: FERNANDEZRIVEIRO LUIS. Apo.Manc.: ROCA SAN JOSE ALBERTO;MOSQUERA RUIZ ADRIAN;MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datosregistrales. T 4320, L 4320, F 220, S 8, H PO 4786, I/A 33 (18.03.21).
20 de Octubre de 2020Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T4320, L 4320, F 220, S 8, H PO 4786, I/A 32 ( 9.10.20).
27 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 136, S 8, H PO 4786, I/A31 (18.05.20).
29 de Julio de 2019Revocaciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORESSLP. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 135, S 8, H PO 4786, I/A 30 (18.07.19).
27 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 136, S 8, H PO 4786, I/A 29(19.10.17).
13 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 135, S 8, H PO4786, I/A 28 ( 5.06.17).
21 de Marzo de 2014Otros conceptos: ACEPTACION Y RATIFICACION DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LA DISOLUCION DE LA SOCIEDADFILIAL "LA TIENDA DEL PUERTO BERBES SL" mediante la cesi贸n global de activos y pasivos a la sociedad CASA BOTAS VIUDADE J MARTINEZ BLASCO SL. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 135, S 8, H PO 4786, I/A 27 (13.03.14).
19 de Marzo de 2014Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 135, S 8, H PO 4786, I/A 25 (11.03.14).
Nombramientos. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 135, S 8, H PO4786, I/A 26 (11.03.14).
07 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS;MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 134, S8, H PO 4786, I/A 24 (28.02.14).
29 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: ROCA SAN JOSE ALBERTO;MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 134, S8, H PO 4786, I/A 23 (23.08.13).
12 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 134, S 8, H PO 4786, I/A 22 ( 4.04.13).
14 de Mayo de 2012P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 133, S 8, H PO 4786, I/A 21 ( 2.05.12).
30 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS. Datos registrales. T 1164, L 1164, F133, S 8, H PO 4786, I/A 20 (18.05.11).
26 de Noviembre de 2009Ampliacion del objeto social. almacenamiento y compraventa de envases y embalajes. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 133, S8, H PO 4786, I/A 19 (13.11.09).
12 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 133, S 8, H PO 4786, I/A 17 (23.12.08).
Reelecciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 1164, L 1164, F 133, S 8, H PO 4786, I/A 18 (23.12.08).