Buscador CIF Logo

Actos BORME Casa Raja Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Casa Raja Sl

Actos BORME Casa Raja Sl - B80583586

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Casa Raja Sl con CIF B80583586

馃敊 Perfil de Casa Raja Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Casa Raja Sl

05 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUIRALTE ABELLO NIEVES;QUIRALTE ABELLO ALVARO-LUIS;QUIRALTE ABELLO SILVIA-PALMIRA;QUIRALTE ABELLO JORGE;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO.Secretario:QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Presidente: QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES. Revocaciones. Apoderado: QUIRALTEABELLO PABLO;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;CAMPO CAMPO LORENZO TOMAS;QUIRALTE ABELLO BLASIGNACIO;QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES;QUIRALTE ABELLO PALMIRA SILVIA;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTEABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Apo.Sol.: QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE.Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: A脩AVETE SL. LAIROCSE SOCIEDAD LIMITADA. SOCITELLO SL.APODACA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA. ALJIBESLLANOS SL. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T21079 , F 207, S 8, H M 101927, I/A 24 (27.02.20).

26 de Diciembre de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.790.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.595.566,00 Euros. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5潞 Y 8潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 21079 , F 206,S 8, H M 101927, I/A 23 (18.12.14).

29 de Octubre de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. ACTIVIDADES DE HOSTELERIATALES COMO HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES, ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTAESTANCIA, RESTAURANTES, PROVISION DE COMIDAS PREPARADAS PARA EVENTOS Y OTROS SERVICIOS DE COMIDAS YESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.- Datos registrales. T 21079 , F 205, S 8, H M 101927, I/A 22 (22.10.14).

20 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUIRALTE ABELLO ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE. Datos registrales. T 21079 , F 205, S 8, H M101927, I/A 21 (12.06.14).

18 de Febrero de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.115.108,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.385.566,00 Euros. Datos registrales. T21079 , F 204, S 8, H M 101927, I/A 20 (10.02.14).

23 de Septiembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 4.350.024,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.500.674,00 Euros. Datos registrales. T21079 , F 203, S 8, H M 101927, I/A 19 (12.09.11).

06 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.850.698,00 Euros. Datos registrales. T 21079 , F 124,S 8, H M 101927, I/A 18 (24.05.11).

16 de Marzo de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: PROYECTO SUBALTE SL. Datos registrales. T 21079 , F 121, S 8, H M 101927,I/A 17 ( 7.03.11).

08 de Febrero de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 539.574,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.650.572,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERAR EL TOTAL DE LAS 3.941.762 PARTICIPACIONES SOCIALES QUE COMPONEN EL CAPITAL SOCIAL. Datosregistrales. T 21079 , F 119, S 8, H M 101927, I/A 15 (27.01.11).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.200.086,00 Euros. Resultante Suscrito: 25.850.658,00 Euros. Datos registrales. T 21079 , F 120,S 8, H M 101927, I/A 16 (27.01.11).

31 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ABELLO GALLO NIEVES. Cons.Del.Sol: ABELLO GALLO NIEVES. Presidente: QUIRALTE ABELLOPABLO. Nombramientos. Presidente: QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES. Apoderado: QUIRALTE ABELLO BLASIGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Reelecciones. Consejero: QUIRALTE ABELLONIEVES;QUIRALTE ABELLO ENRIQUE;QUIRALTE ABELLO ALVARO-LUIS;QUIRALTE ABELLO SILVIA-PALMIRA;QUIRALTEABELLO JORGE;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO. Secretario: QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Cambio de domicilio social. C/ PONZANO N潞 76 (MADRID). Datos registrales. T 21079 , F 118, S 8, H M 101927, I/A 14(20.08.10).

10 de Febrero de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.016.504,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.190.146,00 Euros. Datos registrales. T21079 , F 117, S 8, H M 101927, I/A 13 ( 1.02.10).

02 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES;QUIRALTE ABELLO PALMIRA SILVIA;QUIRALTE ABELLOPABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Datos registrales. T 21079 , F 115, S 8, H M 101927, I/A 12 (23.03.09).

24 de Marzo de 2009
Nombramientos. Apoderado: QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO. Datos registrales. T 21079 , F 114, S 8, H M 101927, I/A 11(11.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n