Actos BORME de Casas De Siete Aguas Sl
22 de Noviembre de 2023Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 206, S 8, H V 51722, I/A 27(15.11.23).
27 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: CUALLADO GASCO MIGUEL. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 206, S 8, H V 51722, I/A 26(20.08.21).
26 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FRANCO BROCH ALEJANDRO. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 205, S 8, H V 51722, I/A 24(19.08.21).
Nombramientos. Apoderado: CARRASCOSA MONTOYA ANTONIO. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 205, S 8, H V 51722, I/A25 (19.08.21).
02 de Febrero de 2021Cambio de domicilio social. AVDA REINO DE VALENCIA 2 - ENTRESUELO (VALENCIA). Datos registrales. T 9520, L 6802, F205, S 8, H V 51722, I/A 23 (26.01.21).
26 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: ZAMORANO SANCHEZ FATIMA. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 203, S 8, H V 51722, I/A 22(19.08.20).
20 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: GALVE JIMENEZ MARIA DEL CARMEN;LLOPIS NAVARRO ALVARO;FRANCO BROCH ALEJANDRO.Datos registrales. T 9520, L 6802, F 203, S 8, H V 51722, I/A 21 (13.08.20).
06 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. C/ ISABEL LA CATOLICA 8 - DESPACHO 13. EDIFICIO CO (VALENCIA). Datos registrales. T 9520,L 6802, F 203, S 8, H V 51722, I/A 20 (27.02.19).
30 de Julio de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/8. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 203, S 8, H V 51722, I/A 19(23.07.18).
25 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: VALLE PECHUAN VIDAL LUIS. Apo.Man.Soli: MORET RUIZ DANIEL. Datos registrales. T 9520, L6802, F 202, S 8, H V 51722, I/A 18 (18.06.18).
11 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZAMORANO SANCHEZ ALFONSO. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 202, S 8, H V 51722, I/A 17( 4.04.14).
28 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MORET RUIZ DANIEL;FERNANDEZ LOPEZ CARLOS;ZAMORANO AGUADOALFONSO;ZAMORANO SANCHEZ MARTIN;ZAMORANO SANCHEZ ALFONSO. Presidente: ZAMORANO AGUADO ALFONSO.Secretario: ZAMORANO SANCHEZ ALFONSO. Cons.Del.Sol: ZAMORANO AGUADO ALFONSO. Cons.Del.Man: ZAMORANOSANCHEZ MARTIN;ZAMORANO SANCHEZ ALFONSO;FERNANDEZ LOPEZ CARLOS;MORET RUIZ DANIEL. Consejero:ZAMORANO SANCHEZ JUAN MARIA. Cons.Del.Man: ZAMORANO SANCHEZ JUAN MARIA. Nombramientos. Adm. Unico:GRUPO AZA VALENCIA SL. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Artículo de los estatutos: ARTICULO11º. DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. El órgano de administración de esta sociedad estará constituido, según decida la JuntaGeneral y sin necesidad de modificar Estatutos, mediante acuerdo adoptado con lamayoría extraordinaria prevista en el artículoanterior. Otros conceptos: La mercantil "Grupo Aza Valencia SL", ha designado a don Alfonso Zamorano Aguado, como su personafisica representante. Datos registrales. T 5671, L 2978, F 119, S 8, H V 51722, I/A 11 (19.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZAMORANO SANCHEZ ALFONSO. Datos registrales. T 5671, L 2978, F 119, S 8, H V 51722, I/A12 (19.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZAMORANO SANCHEZ MARTIN. Datos registrales. T 5671, L 2978, F 120, S 8, H V 51722, I/A 13(19.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZAMORANO SANCHEZ JUAN MARIA. Datos registrales. T 5671, L 2978, F 121, S 8, H V 51722,I/A 14 (19.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORET RUIZ DANIEL. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 201, S 8, H V 51722, I/A 15 (19.11.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORCAR VAQUERO JOSE. Datos registrales. T 9520, L 6802, F 201, S 8, H V 51722, I/A 16(19.11.12).