Buscador CIF Logo

Actos BORME Casavo Gamma Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Casavo Gamma Spain Sl

Actos BORME Casavo Gamma Spain Sl - B05335914

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Casavo Gamma Spain Sl con CIF B05335914

馃敊 Perfil de Casavo Gamma Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Casavo Gamma Spain Sl

28 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: CASAVO MANAGEMENT SPAIN SL. Datos registrales. T 41862 , F 171, S 8, H M 739999, I/A 19(21.03.23).

02 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: TINACCI GIORGIO;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO;COSTA MENESES AXEL.Apo.Man.Soli: NIETO RAMOS ANA MARIA;TABOADA PINZON FERNANDO;MORENO JULIETA;GARCIA SANCHEZ-ROMEROPILAR;GIL LOPEZ MARIO;COSTA MENESES AXEL;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO. Apoderado: TISNER MARMOLFERNANDO;VI脩AS RUIZ MARIO. Apo.Sol.: HUARTE UHAGON PABLO. Apoderado: SANCHEZ-RAMADE GOMEZ ALVARO;NEGROANDREA;ROUCO ALEXANDRE;CASANOVA MANAGEMENT SPAIN SL;SOL CARBONELL ARIADNA;SOKOLOVA ELENA. Datosregistrales. T 41862 , F 170, S 8, H M 739999, I/A 18 (23.02.23).

29 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: SOL CARBONELL ARIADNA. Datos registrales. T 41862 , F 167, S 8, H M 739999, I/A 16 (22.09.22).

Nombramientos. Apoderado: SOKOLOVA ELENA. Datos registrales. T 41862 , F 169, S 8, H M 739999, I/A 17 (22.09.22).

25 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: CASANOVA MANAGEMENT SPAIN SL. Datos registrales. T 41862 , F 166, S 8, H M 739999, I/A 14(18.08.22).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: STICHING BATTISTI. Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SIERRAMARTINEZ FRANCISCO AMERICO;TINACCI GIORGIO. Nombramientos. Adm. Solid.: TORREJON LUNASANTIAGO;SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradoresmancomunados a Administradores solidarios. Datos registrales. T 41862 , F 167, S 8, H M 739999, I/A 15 (18.08.22).

24 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: NEGRO ANDREA. Datos registrales. T 41862 , F 163, S 8, H M 739999, I/A 12 (17.03.22).

Nombramientos. Apoderado: ROUCO ALEXANDRE. Datos registrales. T 41862 , F 165, S 8, H M 739999, I/A 13 (17.03.22).

22 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: HUARTE UHAGON PABLO. Datos registrales. T 41862 , F 160, S 8, H M 739999, I/A 10 (15.03.22).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ-RAMADE GOMEZ ALVARO. Datos registrales. T 41862 , F 162, S 8, H M 739999, I/A 11(15.03.22).

28 de Julio de 2021
Cambio de domicilio social. C/ GENOVA 20 3 (MADRID). Datos registrales. T 41862 , F 160, S 8, H M 739999, I/A 9 (21.07.21).

27 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: TISNER MARMOL FERNANDO. Datos registrales. T 41775 , F 7, S 8, H M 739999, I/A 7 (20.07.21).

Nombramientos. Apoderado: VI脩AS RUIZ MARIO. Datos registrales. T 41775 , F 9, S 8, H M 739999, I/A 8 (20.07.21).

12 de Julio de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIETO RAMOS ANA MARIA;TABOADA PINZON FERNANDO;MORENO JULIETA;GARCIASANCHEZ-ROMERO PILAR;GIL LOPEZ MARIO;COSTA MENESES AXEL;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO. Datosregistrales. T 41775 , F 7, S 8, H M 739999, I/A 6 ( 5.07.21).

14 de Junio de 2021
Modificaciones estatutarias. 7. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 41775 , F 6, S 8, H M 739999, I/A 5 ( 7.06.21).

07 de Junio de 2021
Revocaciones. Apoderado: TINACCI GIORGIO;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO;COSTA MENESES AXEL.Nombramientos. Apoderado: TINACCI GIORGIO;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO;COSTA MENESES AXEL. Datosregistrales. T 41775 , F 5, S 8, H M 739999, I/A 4 (31.05.21).

17 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: TINACCI GIORGIO;SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO;COSTA MENESES AXEL. Datosregistrales. T 41775 , F 3, S 8, H M 739999, I/A 2 (10.05.21).

Nombramientos. Apoderado: ESCRIBA DE ROMANI MORALES ARCE IGNACIO;BARRIO CASTRODEZA CARLOTA;LUCASMARTIN ELISA PILAR;GUZMAN GUZMAN CATALINA JUANA. Datos registrales. T 41775 , F 4, S 8, H M 739999, I/A 3 (10.05.21).

20 de Abril de 2021
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 8.04.21. Objeto social: - La compra de terrenos, inmuebles y partes de inmuebles porcuenta propia, as铆 como de las unidades que ordenan la construcci贸n, parcelaci贸n y urbanizaci贸n de alojamientos, en todos los casoscon el fin de venderlos. - La urbanizaci贸n y parcelaci贸n de terrenos y solares y construcci贸n de edificios. Domicilio: PASEO DE LACASTELLANA 43 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CASAVO SUBHOLDINGSPAIN SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: SIERRA MARTINEZ FRANCISCO AMERICO;TINACCI GIORGIO. Datos registrales. T41775 , F 1, S 8, H M 739999, I/A 1 (13.04.21).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n