Actos BORME de Casdi Sl
18 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: IRIGUIBEL LOPEZ IGOR;ORCOYEN ROMEO JOSE IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: RUIZSALINAS CAROLINA;ORCOYEN ROMEO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 715 , F 61, S 8, H NA 2649, I/A 58 (11.02.22).
27 de Enero de 2022Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ABAIGAR GESTION INMOBILIARIA SL. Datos registrales. T 715 , F 60, S 8, H NA2649, I/A 57 (19.01.22).
16 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: ALER AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ALER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 715 , F 60, S 8, H NA2649, I/A 56 ( 2.12.21).
05 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: IRIGUIBEL LOPEZ IGOR;MANSO MATIENZO FRANCISCO JAVIER;MUNARRIZ RODRIGUEZALBERTO LUIS. Nombramientos. Apoderado: IRIGUIBEL LOPEZ IGOR;ORCOYEN ROMEO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T715 , F 58, S 8, H NA 2649, I/A 54 (26.10.21).
07 de Mayo de 2019Nombramientos. Auditor: ALER AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ALER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 715 , F 58, S 8, H NA2649, I/A 53 (25.04.19).
10 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: MURILLO GIMILIO ANGEL;RUIZ SALINAS CAROLINA;ORCOYEN ROMEO JOSE IGNACIO;MANSOMATIENZO FRANCISCO JAVIER;MUNARRIZ RODRIGUEZ ALBERTO LUIS. Datos registrales. T 715 , F 57, S 8, H NA 2649, I/A 51( 1.04.19).
Nombramientos. Apoderado: IRIGUIBEL LOPEZ IGOR;MANSO MATIENZO FRANCISCO JAVIER;MUNARRIZ RODRIGUEZALBERTO LUIS. Datos registrales. T 715 , F 57, S 8, H NA 2649, I/A 52 ( 1.04.19).
09 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: EQUIZA REYES MARTA. Datos registrales. T 715 , F 57, S 8, H NA 2649, I/A 50 (28.02.18).
31 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: MURILLO GIMILIO ANGEL. Datos registrales. T 715 , F 56, S 8, H NA 2649, I/A 48 (23.08.17).
Nombramientos. Apoderado: MURILLO GIMILIO ANGEL;RUIZ SALINAS CAROLINA;ORCOYEN ROMEO JOSE IGNACIO;EQUIZAREYES MARTA;MANSO MATIENZO FRANCISCO JAVIER;MUNARRIZ RODRIGUEZ ALBERTO LUIS. Datos registrales. T 715 , F56, S 8, H NA 2649, I/A 49 (23.08.17).
27 de Abril de 2017Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SADA DANIEL. Datos registrales. T 715 , F 56, S 8, H NA 2649, I/A 47 ( 5.04.17).
17 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: CA脩AS APARICIO ANA. Datos registrales. T 715 , F 56, S 8, H NA 2649, I/A 46 ( 3.11.16).
26 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: PEREZ LASECA JUAN JOSE. Datos registrales. T 715 , F 55, S 8, H NA 2649, I/A 45 (18.10.16).
11 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ANSORENA SAN MARTIN MARIA PILAR. Presidente: ANSORENA SAN MARTIN MARIA PILAR.Consejero: ABAIGAR ANSORENA MARIA CRISTINA. Secretario: ABAIGAR ANSORENA MARIA CRISTINA. Consejero: ABAIGARANSORENA ALBERTO;ABAIGAR ANSORENA MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: ABAIGAR ANSORENA MARIA CRISTINA.Nombramientos. Adm. Unico: ABAIGAR ANSORENA MARIA CRISTINA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 715 , F 55, S 8, H NA 2649, I/A 44 (29.05.14).
24 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SADA DANIEL. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SADA DANIEL. Datosregistrales. T 669 , F 117, S 8, H NA 2649, I/A 43 (14.11.11).
19 de Octubre de 2011Cambio de domicilio social. AVDA SANCHO EL FUERTE 21 Esc.DR 1& 2 (PAMPLONA). Datos registrales. T 669 , F 117, S 8, HNA 2649, I/A 42 ( 6.10.11).
22 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: ROS RUIZ DE LARRAMENDI RICARDO. Datos registrales. T 669 , F 117, S 8, H NA002649, I/A00041(11.10.10).
05 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SADA DANIEL. Datos registrales. T 669 , F 116, S 8, H NA002649, I/A00040(27.01.09).