Actos BORME de Caser Residencial Sa
05 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO PAREDERO ANNA. Datos registrales. T 45318 , F 102, S 8, H M 156578, I/A 222 (28.11.23).
06 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 45318 , F 102, S 8, H M 156578, I/A 221 (27.10.23).
10 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: OSUNA IZQUIERDO CESAR. Datos registrales. T 45318 , F 101, S 8, H M 156578, I/A 220 (3.10.23).
06 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: PORTILLO CAMPINI ADOLFO. Datos registrales. T 45318 , F 100, S 8, H M 156578, I/A 218(29.09.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HERRERO GARBIKUNDE. Datos registrales. T 45318 , F 100, S 8, H M 156578, I/A 219(29.09.23).
28 de Septiembre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: C Y E BADAJOZ SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA. Datos registrales. T 44585 ,
26 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apoderado: GRANJA RUIZ GEMMA. Datos registrales. T 44585 , F 137, S 8, H M 156578, I/A 216 (19.09.23).
03 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: CANO CRUZ SUSANA. Datos registrales. T 44585 , F 134, S 8, H M 156578, I/A 211 (26.07.23).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ESTEBAN MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 44585 , F 135, S 8, H M 156578,I/A 212 (26.07.23).
Revocaciones. Apoderado: DELGADO URREA SUSANA;RUIZ ULLATE NURIA;RUBIO VALOR PABLO. Apo.Sol.: RUBIO VALORPABLO. Datos registrales. T 44585 , F 136, S 8, H M 156578, I/A 213 (26.07.23).
Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 44585 , F 136, S 8, H M 156578, I/A 214 (26.07.23).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPA脩IA DE SEGUROS YREA. Datos registrales. T 44585 , F 137, S 8, H M 156578, I/A 215 (26.07.23).
19 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO PAREDERO ANNA. Datos registrales. T 44585 , F 131, S 8, H M 156578, I/A 209 (12.07.23).
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CASER RESIDENCIAL GESTION SL. Datos registrales. T 44585 , F 132, S 8, H M156578, I/A 210 (12.07.23).
16 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: ABAJO MENGUEZ MARIO. Datos registrales. T 37829 , F 101, S 8, H M 156578, I/A 207 ( 8.05.23).
11 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA GARCIA VALENTIN. Nombramientos. Consejero: ABAJO MENGUEZ MARIO. Datosregistrales. T 37829 , F 100, S 8, H M 156578, I/A 203 ( 4.05.23).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ALEGRE MARIA DOLORES. Datos registrales. T 37829 , F 100, S 8, H M 156578, I/A204 ( 4.05.23).
Revocaciones. Apoderado: DE MIGUEL SANCHEZ MAYLA. Datos registrales. T 37829 , F 100, S 8, H M 156578, I/A 205 (4.05.23).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA BARRIALES DINA. Datos registrales. T 37829 , F 100, S 8, H M 156578, I/A 206 ( 4.05.23).
24 de Marzo de 2023Modificaciones estatutarias. Derogados los estatutos sociales y aprobado un nuevo texto 铆ntegro.. Datos registrales. T 37829 , F98, S 8, H M 156578, I/A 202 (16.03.23).
03 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: ENRIQUEZ VALCARCEL EDUARDO. Datos registrales. T 37829 , F 97, S 8, H M 156578, I/A 201(24.02.23).
25 de Noviembre de 2022Otros conceptos: SUBSANACION DE LAS INSCRIPCIONES 8陋 Y 16陋 DE LA HOJA SOCIAL, EN CUANTO AL VALOR NOMINALDE LAS ACCIONES Y CONSECUENTE MODIFICACION DEL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T37829 , F 97, S 8, H M 156578, I/A 200 (18.11.22).
31 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: POMBO RODRIGUEZ JESUS. Datos registrales. T 37829 , F 96, S 8, H M 156578, I/A 199(24.10.22).
14 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: PEREZ TRILLO BLANCO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 37829 , F 96, S 8, H M 156578, I/A198 ( 6.10.22).
10 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: TOTANA GARCIA MARIA CONSUELO. Datos registrales. T 37829 , F 96, S 8, H M 156578, I/A 197 (3.10.22).
21 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ GORDALIZA DIANA. Datos registrales. T 37829 , F 95, S 8, H M 156578, I/A 196 (14.07.22).
01 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 37829 , F 93, S 8, H M 156578, I/A 194(24.06.22).
Nombramientos. Apoderado: DE MIGUEL SANCHEZ MAYLA. Datos registrales. T 37829 , F 95, S 8, H M 156578, I/A 195(24.06.22).
23 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Apoderado: DIEZBARCENILLA JOSE MANUEL;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Apoderado: DIEZBARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 37829 , F 93, S 8, H M 156578, I/A 193 (16.06.22).
26 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 21 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 37829 , F 92, S 8, H M156578, I/A 192 (19.05.22).
25 de Mayo de 2022Reelecciones. Consejero: GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 37829 , F 92, S 8, H M 156578, I/A 191 (18.05.22).
09 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Secretario: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL.Nombramientos. Consejero: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Secretario: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T37829 , F 92, S 8, H M 156578, I/A 190 ( 2.03.22).
07 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: VALLS ALEA MARIA-ROSA. Datos registrales. T 37829 , F 92, S 8, H M 156578, I/A 189 (30.09.21).
27 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GONZALEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 37829 , F 91, S 8, H M 156578, I/A 188(20.09.21).
16 de Agosto de 2021Revocaciones. Apoderado: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Apo.Sol.: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Apoderado:PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Apo.Sol.: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Apoderado: PELAEZ RODRIGUEZ JOSEALBERTO. Datos registrales. T 37829 , F 91, S 8, H M 156578, I/A 187 ( 9.08.21).
28 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ ROLDAN LORENA. Datos registrales. T 37829 , F 90, S 8, H M 156578, I/A 186(21.07.21).
19 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 37829 , F 90, S 8, H M 156578, I/A 185 (12.07.21).
18 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: VALLS ALEA MARIA-ROSA. Datos registrales. T 37829 , F 89, S 8, H M 156578, I/A 184 (11.05.21).
13 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: CAMPOS CARRILLO PASCUALA. Datos registrales. T 37829 , F 88, S 8, H M 156578, I/A 183 (6.04.21).
26 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: UBEDA PRIETO ARTURO. Datos registrales. T 37829 , F 87, S 8, H M 156578, I/A 181 (19.03.21).
Revocaciones. Apoderado: PALLARES RAMIREZ PEDRO;DIAZ AGUILERA JUAN. Datos registrales. T 37829 , F 88, S 8, H M156578, I/A 182 (19.03.21).
10 de Febrero de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37829 , F 87, S 8, H M 156578, I/A 180 ( 3.02.21).
10 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: ROMERO ALCALDE MIGUEL. Datos registrales. T 37829 , F 86, S 8, H M 156578, I/A 179 ( 1.12.20).
30 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: SIERRA GARCIA SONIA. Datos registrales. T 37829 , F 86, S 8, H M 156578, I/A 178 (23.10.20).
09 de Julio de 2020Revocaciones. Apoderado: LOZANO PEREZ JESUS. Datos registrales. T 37829 , F 86, S 8, H M 156578, I/A 177 ( 2.07.20).
16 de Junio de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MOLINA MARTIN ALBERTO. Datos registrales. T 37829 , F 85, S 8, H M 156578, I/A 176 ( 9.06.20).
25 de Mayo de 2020Reelecciones. Consejero: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Secretario: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales.T 37829 , F 85, S 8, H M 156578, I/A 175 (18.05.20).
20 de Abril de 2020Nombramientos. Apoderado: RUBIO VALOR PABLO. Datos registrales. T 37829 , F 84, S 8, H M 156578, I/A 173 (13.04.20).
Nombramientos. Apoderado: LASUEN URREJOLA I脩IGO. Datos registrales. T 37829 , F 85, S 8, H M 156578, I/A 174 (13.04.20).
11 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: RUIZ ULLATE NURIA. Datos registrales. T 37829 , F 83, S 8, H M 156578, I/A 172 ( 4.03.20).
31 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: LOSTAO OTERO MARIA CARMEN. Datos registrales. T 37829 , F 83, S 8, H M 156578, I/A 171(24.10.19).
28 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: BESCOND AUDE GWENDOLINE RAPHAELLE. Datos registrales. T 37829 , F 82, S 8, H M 156578, I/A170 (21.10.19).
29 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 37829 , F 82, S 8, H M 156578, I/A 169 (22.08.19).
25 de Julio de 2019Revocaciones. Apoderado: LIZARRAGA ARMENTIA VIRGINIA. Datos registrales. T 37829 , F 82, S 8, H M 156578, I/A 168(18.07.19).
22 de Mayo de 2019Reelecciones. Consejero: DE LORENZO LOPEZ FERNANDO. Presidente: DE LORENZO LOPEZ FERNANDO. Datos registrales.T 37829 , F 82, S 8, H M 156578, I/A 167 (14.05.19).
17 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: REQUENA GOMEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 37829 , F 82, S 8, H M 156578, I/A 166 ( 9.10.18).
28 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31991 , F 61, S 8, H M 156578, I/A 165 (21.08.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOSTAO OTERO MARIA CARMEN. Datos registrales. T 31991 , F 61, S 8, H M 156578, I/A 164(16.07.18).
23 de Enero de 2018Revocaciones. Apoderado: GARCIA-SAMPEDRO IGEA MELCHOR. Datos registrales. T 31991 , F 61, S 8, H M 156578, I/A 163(16.01.18).
29 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: DIAZ AGUILERA JUAN. Datos registrales. T 31991 , F 60, S 8, H M 156578, I/A 162 (21.11.17).
13 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31991 , F 60, S 8, H M 156578, I/A 161 (31.08.17).
24 de Mayo de 2017Reelecciones. Consejero: GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 31991 , F 60, S 8, H M 156578, I/A 160 (16.05.17).
12 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA VALENTIN;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSEALBERTO Datos registrales. T 31991 , F 59, S 8, H M 156578, I/A 158 ( 5.05.17).
Nombramientos. Apoderado: VELOSO BORREGO ASUNCION. Datos registrales. T 31991 , F 59, S 8, H M 156578, I/A 159 (5.05.17).
06 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: LIZARRAGA ARMENTIA VIRGINIA. Datos registrales. T 31991 , F 58, S 8, H M 156578, I/A 157(30.01.17).
20 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: REQUENA GOMEZ MARIA JOSE;DE LA FUENTE VALLES MARIA ELENA. Datos registrales. T 31991, F 58, S 8, H M 156578, I/A 156 (13.10.16).
29 de Julio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GARMENDIA FERNANDEZ JESUS MARIA;FUENTES DIAZ VIRGINIA;PELAEZ RODRIGUEZ JOSEALBERTO. Datos registrales. T 31991 , F 57, S 8, H M 156578, I/A 155 (20.07.16).
22 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: DELGADO URREA SUSANA. Datos registrales. T 31991 , F 57, S 8, H M 156578, I/A 153 (14.06.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: HIDALGO BUITRAGO INMACULADA. Datos registrales. T 31991 , F 57, S 8, H M 156578, I/A 154(14.06.16).
07 de Junio de 2016Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 31991 , F 56, S 8, H M 156578, I/A 151(30.05.16).
Nombramientos. Apoderado: TELLERIA LAZARO IGNACIO MARIA. Datos registrales. T 31991 , F 56, S 8, H M 156578, I/A 152(30.05.16).
21 de Enero de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA VALENTIN;GARCIA ORTIZ ANTONIO;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 31991 , F 55, S 8, H M 156578, I/A 150 (14.01.16).
12 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: HIDALGO BUITRAGO INMACULADA. Datos registrales. T 31991 , F 55, S 8, H M 156578, I/A 149(31.07.15).
24 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA-SAMPEDRO IGEA MELCHOR. Datos registrales. T 31991 , F 54, S 8, H M 156578, I/A 148(16.06.15).
18 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: PIQUER GOMEZ ANA. Datos registrales. T 31991 , F 54, S 8, H M 156578, I/A 146 (11.06.15).
Nombramientos. Apoderado: DE LORENZO LOPEZ FERNANDO;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSEALBERTO. Datos registrales. T 31991 , F 54, S 8, H M 156578, I/A 147 (11.06.15).
05 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: TOTANA GARCIA MARIA CONSUELO. Datos registrales. T 31991 , F 53, S 8, H M 156578, I/A 145(27.05.15).
26 de Mayo de 2015Reelecciones. Consejero: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Secretario: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales.T 31991 , F 53, S 8, H M 156578, I/A 144 (19.05.15).
01 de Octubre de 2014Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31991 , F 53, S 8, H M 156578, I/A 143 (23.09.14).
09 de Junio de 2014Reelecciones. Consejero: DE LORENZO LOPEZ FERNANDO. Presidente: DE LORENZO LOPEZ FERNANDO. Datos registrales.T 26094 , F 29, S 8, H M 156578, I/A 142 (30.05.14).
10 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: CARDONA GARCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 26094 , F 29, S 8, H M 156578, I/A 141 ( 3.04.14).
07 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: RUBIN ALVAREZ JACOBO. Datos registrales. T 26094 , F 29, S 8, H M 156578, I/A 140 (28.03.14).
25 de Marzo de 2014Revocaciones. Apoderado: NAVARRO OLIVA ANA. Datos registrales. T 26094 , F 29, S 8, H M 156578, I/A 139 (17.03.14).
07 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: PIQUER GOMEZ ANA. Datos registrales. T 26094 , F 28, S 8, H M 156578, I/A 138 (30.01.14).
16 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: LAZARO SANCHEZ CRISTINA. Datos registrales. T 26094 , F 28, S 8, H M 156578, I/A 137 ( 5.12.13).
04 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: BLASCO DIONIS ALBERTO. Datos registrales. T 26094 , F 28, S 8, H M 156578, I/A 136 (21.11.13).
27 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: SAN EMETERIO CUESTA MERTXE. Datos registrales. T 26094 , F 27, S 8, H M 156578, I/A 135(19.11.13).
26 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: NAVARRO OLIVA ANA. Datos registrales. T 26094 , F 26, S 8, H M 156578, I/A 133 (15.11.13).
Nombramientos. Apoderado: VELOSO SOTO MARIA. Datos registrales. T 26094 , F 27, S 8, H M 156578, I/A 134 (15.11.13).
08 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: CARDONA GARCIA ENRIQUE. Apoderado: TRIMI脩O BELTRAN JOSE MANUEL. Datos registrales. T26094 , F 26, S 8, H M 156578, I/A 132 (31.07.13).
01 de Agosto de 2013Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ BAYON ANA BEATRIZ;BLASCO DIONIS ALBERTO;TIZON ASTIASARAIN NEREA;LOZANOPEREZ JESUS. Datos registrales. T 26094 , F 25, S 8, H M 156578, I/A 130 (24.07.13).
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ PARDO LAURA;RUIZ VICENTE MARTA;LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE;LUIS ABADCARMELI;MANUEL CANALS ANNA MARIA;GUERRERO PUGA NURIA;RODRIGUEZ ZAMARRE脩O LAURA;PALOMO POLONIOMARIA DEL PRADO;SIERRA GARCIA SONIA;GUERRERO PUGA NURIA;SIERRA GARCIA SONIA;RUIZ VICENTEMARTA;PALOMO POLONIO MARIA DEL PRADO;LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE;LUIS ABAD CARMELIA;RODRIGUEZZAMARRE脩O LAURA;PALLARES RAMIREZ PEDRO;PALLARES RAMIREZ PEDRO. Datos registrales. T 26094 , F 25, S 8, H M156578, I/A 131 (25.07.13).
12 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26094 , F 25, S 8, H M 156578, I/A129 ( 3.07.13).
19 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: BESCOND AUDE GWENDOLINE RAPHAELLE;PALOMO POLONIO MARIA DEL PRADO;RUIZVICENTE MARTA;BLASCO DIONIS ALBERTO;LUIS ABAD CARMELIA;LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE;TIZON ASTIASARAINNEREA;SIERRA GARCIA SONIA;GUERRERO PUGA NURIA;LOZANO PEREZ JESUS;PALLARES RAMIREZ PEDRO;ALVAREZBAYON ANA BEATRIZ;RODRIGUEZ ZAMARRE脩O LAURA;TRIMI脩O BELTRAN JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26094 , F 22,S 8, H M 156578, I/A 127 (11.06.13).
Nombramientos. Apoderado: CARDONA GARCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 26094 , F 23, S 8, H M 156578, I/A 128(11.06.13).
29 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: TORRES COSTAS MARIA EUGENIA. Apoderado: TORRES COSTAS MARIA EUGENIA. Datosregistrales. T 26094 , F 22, S 8, H M 156578, I/A 126 (22.04.13).
20 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: RUIZ CEJUDO MARIA. Datos registrales. T 26094 , F 22, S 8, H M 156578, I/A 125 ( 8.11.12).
08 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: CARDONA GARCIA ENRIQUE. Datos registrales. T 26094 , F 21, S 8, H M 156578, I/A 124 (26.10.12).
20 de Junio de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26094 , F 20, S 8, H M 156578, I/A122 ( 7.06.12).
Reelecciones. Consejero: GARCIA GARCIA VALENTIN. Datos registrales. T 26094 , F 20, S 8, H M 156578, I/A 123 ( 8.06.12).
22 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: LOZANO PEREZ JESUS. Datos registrales. T 26094 , F 19, S 8, H M 156578, I/A 121 ( 8.05.12).
25 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ RUEDA LIDIA;MENDIOLA MARTINEZ TOMAS. Datos registrales. T 26094 , F 19, S 8, HM 156578, I/A 120 (14.04.12).
17 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ JOSE;FERNANDEZ SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 26094 , F 19, S 8,H M 156578, I/A 119 ( 6.02.12).
13 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ BAYON ANA BEATRIZ;MENDIOLA MARTINEZ TOMAS;BLASCO DIONIS ALBERTO;TIZONASTIASARAIN NEREA. Datos registrales. T 26094 , F 18, S 8, H M 156578, I/A 118 ( 1.02.12).
07 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES;FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES. Datosregistrales. T 26094 , F 18, S 8, H M 156578, I/A 117 (26.01.12).
07 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RUEDA LIDIA. Datos registrales. T 26094 , F 17, S 8, H M 156578, I/A 116 (24.11.11).
05 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: VINTANEL CORZAN DAVID;VINTANEL CORZAN DAVID. Datos registrales. T 26094 , F 17, S 8, H M156578, I/A 115 (23.11.11).
25 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: ENTRENA VICEN BELEN. Datos registrales. T 26094 , F 17, S 8, H M 156578, I/A 114 (15.11.11).
16 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26094 , F 16, S 8, H M 156578, I/A113 ( 3.11.11).
29 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: PALLARES RAMIREZ PEDRO. Datos registrales. T 26094 , F 16, S 8, H M 156578, I/A 112(16.06.11).
09 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: VELOSO BORREGO ASUNCION. Datos registrales. T 26094 , F 15, S 8, H M 156578, I/A 111(31.01.11).
08 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: RUIZ CEJUDO MARIA. Datos registrales. T 26094 , F 14, S 8, H M 156578, I/A 110 (26.01.11).
21 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26094 , F 12, S 8, H M 156578, I/A 109(11.01.11).
19 de Enero de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FELGUEROSO FUENTES ERNESTO;GARMENDIA FERNANDEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T26094 , F 12, S 8, H M 156578, I/A 108 ( 7.01.11).
14 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: DE LUCAS ALCOCER MARIA DEL CARMEN;DE LUCAS ALCOCER MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 26094 , F 12, S 8, H M 156578, I/A 107 (30.11.10).
14 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: PALLARES RAMIREZ PEDRO. Datos registrales. T 26094 , F 10, S 8, H M 156578, I/A 106 (1.10.10).
06 de Mayo de 2010Modificaciones estatutarias. 21. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 26094 , F 8, S 8, H M 156578, I/A 103(26.04.10).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VINTANEL EMBARBA ANTONIO. Apo.Sol.: VINTANEL EMBARBA ANTONIO. Apoderado: VINTANELEMBARBA ANTONIO;GARCIA GARCIA VALENTIN;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26094 , F 8, S 8, H M156578, I/A 104 (26.04.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA VALENTIN;GARCIA ORTIZ ANTONIO;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 26094 , F 9, S 8, H M 156578, I/A 105 (26.04.10).
15 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ENTRENA VICEN BELEN. Datos registrales. T 26094 , F 7, S 8, H M 156578, I/A 102 ( 4.03.10).
05 de Marzo de 2010Nombramientos. Consejero: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 26094 , F 7, S 8, H M 156578, I/A 101(23.02.10).
26 de Febrero de 2010Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ ZAMARRE脩O LAURA. Datos registrales. T 26094 , F 6, S 8, H M 156578, I/A 100(16.02.10).
22 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: VINTANEL EMBARBA ANTONIO. Datos registrales. T 26094 , F 6, S 8, H M 156578, I/A 99(10.02.10).
22 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: GUERRERO PUGA NURIA;SIERRA GARCIA SONIA;RUIZ VICENTE MARTA;PALOMO POLONIOMARIA DEL PRADO;FERNANDEZ SANCHEZ JOSE;LOPEZ GONZALEZ JUAN JOSE;LUIS ABAD CARMELIA;DE LUCAS ALCOCERMARIA DEL CARMEN;TORRES COSTAS MARIA EUGENIA;FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ANGELES;LAZARO SANCHEZCRISTINA. Datos registrales. T 26094 , F 5, S 8, H M 156578, I/A 98 ( 5.01.10).
11 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T26094 , F 4, S 8, H M 156578, I/A 97 (27.11.09).
24 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: VINTANEL EMBARBA ANTONIO;DE LORENZO LOPEZ FERNANDO. Presidente: DE LORENZO LOPEZFERNANDO. Datos registrales. T 26094 , F 4, S 8, H M 156578, I/A 96 (11.08.09).
19 de Junio de 2009Revocaciones. Apoderado: STANIMIROVA ELENA ALEKSANDROVA. Datos registrales. T 26094 , F 3, S 8, H M 156578, I/A 94 (8.06.09).
Nombramientos. Apoderado: SIERRA GARCIA SONIA. Datos registrales. T 26094 , F 3, S 8, H M 156578, I/A 95 ( 8.06.09).
08 de Mayo de 2009Revocaciones. Apoderado: LOPEZ GONZALEZ SONIA. Datos registrales. T 26094 , F 2, S 8, H M 156578, I/A 92 (28.04.09).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 26094 , F 2, S 8, H M 156578, I/A 93 (28.04.09).
14 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: STANIMIROVA ELENA ALEKSANDROVA. Datos registrales. T 26094 , F 1, S 8, H M 156578, I/A 91(31.03.09).