Actos BORME de Caser Servicios De Salud Sa
18 de Octubre de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.506.000,00 Euros. Desembolsado: 4.506.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.116.000,00 Euros.
17 de Octubre de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37911 , F 122, S 8, H M 307152, I/A 77 ( 9.10.23).
15 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Apoderado: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T37911 , F 122, S 8, H M 307152, I/A 76 ( 8.09.23).
03 de Agosto de 2023Nombramientos. Apoderado: HOYO MU脩OZ PEDRO GREGORIO. Datos registrales. T 37911 , F 122, S 8, H M 307152, I/A 75(27.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: COSTALES ARTIEDA JUAN RAMON;PUCHE PAJARES DANIEL;ZORITA GONZALEZCONSUELO;MARQUEZ PRADERA JORGE;ARRIBAS PEREZ ELENA;MOLINA MORALES JUAN. Datos registrales. T 37911 , F121, S 8, H M 307152, I/A 74 (20.07.23).
26 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 37911 , F 121, S 8, H M 307152, I/A 73(19.07.23).
08 de Junio de 2023Revocaciones. Apoderado: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO;BERMEJO ALBARES ILDEFONSO. Datos registrales. T 37911 , F120, S 8, H M 307152, I/A 70 ( 1.06.23).
02 de Junio de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Desembolsado: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.610.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 13.610.000,00 Euros. Datos registrales. T 37911 , F 120, S 8, H M 307152, I/A 69 (26.05.23).
16 de Marzo de 2023Cambio de objeto social. La comercializaci贸n y explotaci贸n de servicios y cl铆nicas sanitarias, as铆 como la comercializaci贸n deproductos y servicios sanitarios, de est茅tica y cuidado de las personas. La prestaci贸n de servicios m茅dicos a personas y colectivos,incluyendo la informaci贸n, el diagn贸stico. Datos registrales. T 37911 , F 120, S 8, H M 307152, I/A 68 ( 9.03.23).
10 de Febrero de 2023Nombramientos. Apoderado: MARCOS HERNAN JESUS. Datos registrales. T 37911 , F 118, S 8, H M 307152, I/A 66 ( 3.02.23).
Nombramientos. Apoderado: MARCOS HERNAN JESUS. Datos registrales. T 37911 , F 119, S 8, H M 307152, I/A 67 ( 3.02.23).
29 de Noviembre de 2022Nombramientos. Apoderado: PEREZ TRILLO BLANCO JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 37911 , F 118, S 8, H M 307152, I/A65 (22.11.22).
17 de Octubre de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.250.000,00 Euros. Desembolsado: 2.250.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.610.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 11.610.000,00 Euros. Datos registrales. T 37911 , F 118, S 8, H M 307152, I/A 64 ( 7.10.22).
10 de Octubre de 2022Revocaciones. Apoderado: RODRIGO ZARZUELA HELENA;NUNES PEREIRA ANA FILIPA. Datos registrales. T 37911 , F 117, S8, H M 307152, I/A 63 ( 3.10.22).
27 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PISON CARLOS RAMON. Datos registrales. T 37911 , F 117, S 8, H M 307152, I/A 62(19.07.22).
20 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BUZON GARCIA ADOLFO;ALCARAZ ESCRIBANO LAURA. Datos registrales. T 37911 , F 117, S 8, HM 307152, I/A 61 (13.07.22).
13 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: ORTIZ CAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 37911 , F 116, S 8, H M 307152, I/A 60 (6.07.22).
07 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 37911 , F 115, S 8, H M 307152, I/A 59(30.06.22).
01 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ HERRERO EMILIO. Datos registrales. T 37911 , F 115, S 8, H M 307152, I/A 58(24.06.22).
23 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL. Apoderado: DIEZ BARCENILLAJOSE MANUEL. Datos registrales. T 37911 , F 115, S 8, H M 307152, I/A 57 (16.06.22).
14 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: BUZON GARCIA ADOLFO. Datos registrales. T 37911 , F 114, S 8, H M 307152, I/A 56 ( 7.06.22).
22 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: OLANO RUIPEREZ LETICIA. Datos registrales. T 37911 , F 113, S 8, H M 307152, I/A 55 (15.02.22).
16 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: PELAEZ RODRIGUEZ ALBERTO. Apoderado: PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO;PELAEZRODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 37911 , F 113, S 8, H M 307152, I/A 54 ( 9.08.21).
30 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ-HONTORIA GARCIA JAVIER. Datos registrales. T 37911 , F 113, S 8, H M 307152, I/A 52(23.07.21).
Cambio de objeto social. la comercializaci贸n y explotaci贸n de servicios y cl铆nicas de odontolog铆a, la comercializaci贸n de productos yservicios sanitarios, de est茅tica y cuidado de las personas, as铆 como los relacionados con el mantenimiento, reforma y conservaci贸n debienes muebles e inmuebles y cualquier otra actividad... Datos registrales. T 37911 , F 113, S 8, H M 307152, I/A 53 (23.07.21).
19 de Julio de 2021Reelecciones. Adm. Mancom.: NADAL DE DIOS RAMON;AZPEITIA GAMAZO MIGUEL. Datos registrales. T 37911 , F 112, S 8, HM 307152, I/A 51 (12.07.21).
04 de Junio de 2021Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37911 , F 112, S 8, H M 307152, I/A 50 (28.05.21).
26 de Marzo de 2021Nombramientos. Apoderado: BERMEJO ALBARES ILDEFONSO;GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 37911 , F112, S 8, H M 307152, I/A 49 (18.03.21).
06 de Julio de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA FERNANDEZ ANGEL. Datos registrales. T 37911 , F 112, S 8, H M 307152, I/A 48 (29.06.20).
10 de Junio de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ IGNACIO. Datos registrales. T 37911 , F 111, S 8, H M 307152, I/A 47 ( 3.06.20).
08 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-HONTORIA GARCIA JAVIER;NUNES PEREIRA ANA FILIPA. Datos registrales. T 37911, F 110, S 8, H M 307152, I/A 46 (29.04.20).
21 de Abril de 2020Revocaciones. Apoderado: DIAZ BORGHI HORACIO-FERNANDO. Datos registrales. T 37911 , F 109, S 8, H M 307152, I/A 45(14.04.20).
24 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: DIAZ BORGHI JORGE RAUL. Datos registrales. T 37911 , F 109, S 8, H M 307152, I/A 44 (17.02.20).
14 de Noviembre de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.200.000,00 Euros. Desembolsado: 1.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.360.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 9.360.000,00 Euros. Datos registrales. T 37911 , F 109, S 8, H M 307152, I/A 43 ( 7.11.19).
23 de Octubre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: ARRIBAS PEREZ MARIA ELENA. Datos registrales. T 37911 , F 108, S 8, H M 307152, I/A 42(16.10.19).
16 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: DIAZ BORGHI JORGE RAUL. Datos registrales. T 37911 , F 107, S 8, H M 307152, I/A 41 ( 9.10.19).
16 de Abril de 2019Otros conceptos: QUE LA SOCIEDAD "BIOGESDENT SLP" TRANSMITE EN BLOQUE TODO SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD "CASER SERVICIOS DE SALUD, SA".- Datos registrales. T 37911 , F 107, S 8, H M 307152, I/A 40 ( 9.04.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ ARCINIEGA ANTONIO. Datos registrales. T 37911 , F 106, S 8, H M 307152, I/A 39(26.03.19).
18 de Octubre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALENCIA SERRANO LUIS. Datos registrales. T 37911 , F 104, S 8, H M 307152, I/A 37(10.10.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 37911 , F 105, S 8, H M 307152, I/A 38(10.10.18).
11 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: DOMINGUEZ OLIVERA MARIA ANTONIA. Datos registrales. T 37911 , F 104, S 8, H M 307152, I/A 35( 4.09.18).
Revocaciones. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 37911 , F 104, S 8, H M 307152, I/A 36 ( 4.09.18).
01 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 31740 , F 183, S 8, H M 307152, I/A 34 (25.07.18).
20 de Julio de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.900.000,00 Euros. Desembolsado: 5.900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.160.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 8.160.000,00 Euros. Datos registrales. T 31740 , F 183, S 8, H M 307152, I/A 33 (12.07.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: CARRASCO MAZA RODRIGO. Datos registrales. T 31740 , F 183, S 8, H M 307152, I/A 32 ( 9.02.18).
25 de Enero de 2018Nombramientos. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 31740 , F 183, S 8, H M 307152, I/A 31 (17.01.18).
02 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: DIAZ CARRERA CRISTINA. Datos registrales. T 31740 , F 182, S 8, H M 307152, I/A 30 (23.10.17).
21 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MAYOR GARCIA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 31740 , F 182, S 8, H M 307152, I/A 29(14.06.17).
04 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: BARCHINO DE COZAR FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 31740 , F 181, S 8, H M 307152,I/A 28 (27.03.17).
17 de Noviembre de 2016Modificaci贸n de duraci贸n: Indefinida. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 17陋 LA PUBLICACION DELCAMBIO DE DURACION DE LA SOCIEDAD QUE PASA A SER INDEFINIDA. Datos registrales. T 17809 , F 211, S 8, H M 307152,I/A 17 ( 5.02.14).
22 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: DIEZ BARCENILLA JOSE MANUEL;PELAEZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T31740 , F 179, S 8, H M 307152, I/A 26 (12.02.16).
Nombramientos. Apoderado: DIAZ BORGHI HORACIO-FERNANDO;CARRIZO GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 31740 , F179, S 8, H M 307152, I/A 27 (12.02.16).