Actos BORME de Casino Torremar Sa
06 de Octubre de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 190.000,00 Euros. Desembolsado: 190.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 47588 , F 193, S 8, H B 409341, I/A 45 (28.09.23).
14 de Septiembre de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 190.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: BINGOTAR GLOBAL 2023 S.L. Datos registrales. T 47588 , F 191, S 8, H B 409341, I/A 44 ( 7.09.23).
11 de Abril de 2023Cambio de objeto social. LA EXPLOTACION EN REGIMEN DE EMPRESA OPERADORA DE APARATOS DE JUEGO,YMAQUINAS RECREATIVAS O DE AZAR; ASI COMO LAS ACTIVIDADES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE AQUELLAS. LAEXPLOTACION DE APARATOS AUTOMATICOS... Datos registrales. T 47588 , F 191, S 8, H B 409341, I/A 43 (30.03.23).
10 de Agosto de 2022Nombramientos. ADM.UNICO: EGARGAMES SL. Datos registrales. T 47588 , F 191, S 8, H B 409341, I/A 42 ( 2.08.22).
18 de Agosto de 2021Revocaciones. APODERAD.SOL: FERNANDEZ DE ALBA CABRE FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 47588 , F 191, S8, H B 409341, I/A 41 ( 6.08.21).
14 de Enero de 2021Nombramientos. APODERAD.SOL: BARRERA OSORIO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 45177 , F 137, S 8, H B 409341, I/A40 ( 5.01.21).
24 de Mayo de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ VALENCIA DAVID. Datos registrales. T 45177 , F 137, S 8, H B 409341, I/A 39(16.05.19).
29 de Marzo de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: FERNANDEZ DE ALBA CABRE FRANCISCO DE BORJA. Datos registrales. T 45177 , F 136,S 8, H B 409341, I/A 38 (21.03.19).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. APOD.MANCOMU: SANCHEZ GRASA EVA MARIA;BARRERA OSORIO JUAN CARLOS. Datos registrales. T45177 , F 135, S 8, H B 409341, I/A 36 (10.05.18).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PUERTOS PEREZ MARIA. Datos registrales. T 45177 , F 136, S 8, H B 409341, I/A 37(10.05.18).
07 de Marzo de 2018Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: EGARGAMES SL. Nombramientos. ADM.UNICO: EGARGAMES SL. Modificacionesestatutarias. ARTICULO 8.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 45177 , F 135, S8, H B 409341, I/A 34 (28.02.18).
Nombramientos. ADM.UNICO: EGARGAMES SL. Datos registrales. T 45177 , F 135, S 8, H B 409341, I/A 35 (28.02.18).
10 de Enero de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: PUERTOS PEREZ MARIA. Datos registrales. T 45177 , F 134, S 8, H B 409341, I/A 33(28.12.17).
01 de Junio de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: MANCEBO SANCHEZ JAVIER. Datos registrales. T 45177 , F 133, S 8, H B 409341, I/A 30(24.05.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ RAMIREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 45177 , F 133, S 8, H B 409341,I/A 31 (24.05.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: VALL DOMINGUEZ MARIA JOSE. Datos registrales. T 45177 , F 134, S 8, H B 409341, I/A 32(24.05.17).
03 de Mayo de 2017Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: NEW XATO SL. REPR.143 RRM: VALL PLANAS JOSE. Datos registrales. T 45177 , F 132, S 8, HB 409341, I/A 28 (21.04.17).
Nombramientos. APODERAD.SOL: VALL PLANAS JOSE. Datos registrales. T 45177 , F 132, S 8, H B 409341, I/A 29 (21.04.17).
05 de Julio de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 99.800,00 Euros. Desembolsado: 99.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 45177 , F 132, S 8, H B 409341, I/A 27 (28.06.16).
14 de Diciembre de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: RUANO PEREZ TEOFILO. Datos registrales. T 42470 , F 162, S 8, H B 409341, I/A 26 (2.12.15).
09 de Septiembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 88.896,77 Euros. Desembolsado: 88.896,77 Euros. Resultante Suscrito: 150.200,00 Euros.Resultante Desembolsado: 150.200,00 Euros. Cambio de objeto social. (CNAE 9200) A) LA EXPLOTACION DE JUEGOS YAPUESTAS Y ESPECIFICO LA EXPLOTACION DE SALONES RECREATIVOS Y DE JUEGO, DE LOS REGULADOS EN ELDECRETO 180/1987 DE 29 DE JULIO, PUBLICADO EN EL BOJA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1987 POR... Datos registrales. T42470 , F 162, S 8, H B 409341, I/A 25 ( 1.09.15).
21 de Abril de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: RUANO PEREZ TEOFILO. Datos registrales. T 42470 , F 161, S 8, H B 409341, I/A 24(13.04.15).
10 de Diciembre de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: RUANO PEREZ TEOFILO. Datos registrales. T 42470 , F 161, S 8, H B 409341, I/A 23 (2.12.14).
27 de Agosto de 2014Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: NEW XATO SL. REPR.143 RRM: VALL PLANAS JOSE. Datos registrales. T 42470 , F 160, S 8,H B 409341, I/A 22 (19.08.14).
26 de Junio de 2014Nombramientos. APODERAD.SOL: CHELBAT AJOUID LAILA. Datos registrales. T 42470 , F 160, S 8, H B 409341, I/A 21(19.06.14).
17 de Mayo de 2013Nombramientos. APODERADO: BARRERA OSORIO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 42470 , F 160, S 8, H B 409341, I/A 20 (8.05.13).
11 de Octubre de 2012Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: VALL ROYUELA JOSE. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: EGARGAMES SL. REPR.143 RRM:VALL ROYUELA JOSE. Datos registrales. T 42470 , F 159, S 8, H B 409341, I/A 19 ( 1.10.12).
08 de Junio de 2011Nombramientos. APODERADO: MEDINA GARRIDO JUAN. Datos registrales. T 42470 , F 158, S 8, H B 409341, I/A 18 (27.05.11).
28 de Abril de 2011Nombramientos. APODERADO: AREVALO FERNANDEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 42470 , F 158, S 8, H B 409341, I/A17 (13.04.11).
13 de Abril de 2011Cambio de domicilio social. CL COLON Num.535 (TERRASSA). Datos registrales. T 42470 , F 158, S 8, H B 409341, I/A 16 (1.04.11).
21 de Febrero de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MASTREBOL SL. SALONES MADRID GAME SA. Datos registrales. T 1334, L 247,F 200, S 8, H MA 10009, I/A 12 ( 7.02.11).
04 de Noviembre de 2009Reelecciones. Adm. Solid.: NEW XATO SL;VALL ROYUELA JOSE. Datos registrales. T 1334, L 247, F 200, S 8, H MA 10009, I/A11 (22.10.09).