Actos BORME de Casta Arevalo Sl
23 de Octubre de 2018Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 78, S 8, H PO 58874, I/A 32 (16.10.18).
25 de Julio de 2018Otros conceptos: Se modifica el artículo 6º de los estatutos sociales relativo a los DERECHOS REALES DE LASPARTICIPACIONES SOCIALES y se modifica el artículo 8º relativo al REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES.Datos registrales. T 4204, L 4204, F 77, S 8, H PO 58874, I/A 31 (19.07.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 77, S 8, H PO 58874,I/A 30 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 76, S 8, H PO 58874, I/A 29(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 76, S 8, H PO 58874, I/A 28 (6.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: TORRES YAGUE BORJA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 76, S 8, H PO 58874, I/A 27 ( 9.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 76, S 8, H PO 58874, I/A 25 (2.03.18).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 76, S 8, H PO 58874, I/A 26 ( 2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 75, S 8, H PO 58874, I/A22 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 75, S 8, H PO 58874, I/A 23(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 75, S 8, H PO 58874, I/A24 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 73, S 8, H PO 58874, I/A 21 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 73, S 8, H PO 58874, I/A 20(25.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 73, S 8, H PO 58874, I/A 19(21.08.17).
21 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: GINES FERRERO OLGA;GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 73, S 8, H PO58874, I/A 18 (10.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 72, S 8, H PO 58874, I/A 15 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARIÑO MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 72, S 8, H PO 58874, I/A 16 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 73, S 8, H PO 58874, I/A 17 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 72, S 8, H PO 58874, I/A 14(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 70, S 8, H PO 58874, I/A 13(18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 224, S 8, H PO 58874, I/A 11(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 224, S 8, H PO 58874, I/A 12(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 224, S 8, H PO 58874, I/A 10(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 223, S 8, H PO 58874, I/A 9(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 220, S 8, H PO 58874, I/A 8(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 172, S 8, H PO 58874, I/A 7(12.06.17).
17 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: ABASCAL CASTAÑON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 169, S 8, H PO 58874,I/A 6 ( 5.04.17).
14 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: CATENA ASUNSOLO ANGEL. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 169, S 8, H PO 58874, I/A 5 (2.10.15).
25 de Agosto de 2015Revocaciones. Apoderado: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 169, S 8, H PO 58874, I/A 4 (13.08.15).
18 de Agosto de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4060, L 4060, F 145, S 8, H PO 58874, I/A 1(10.08.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL;GINES FERRERO OLGA. Nombramientos. Adm.Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración:Administradores mancomunados a Administrador único. Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 3 de los estatutos socialescorrespondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T 4060, L 4060, F 169, S 8, H PO 58874, I/A 2 (10.08.15).
06 de Mayo de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26560 , F 222, S 8, H M 303693, I/A 31 (27.04.15).
20 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 26560 , F 221, S 8, H M 303693, I/A 30(13.02.15).
13 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Representan: BERMEJO MADERA ALBERTO.Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Datos registrales. T 26560 , F 221, S 8, H M 303693,I/A 29 ( 2.01.15).
28 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL;PENAS GARCIA MARIA-JESUS. Cambio de domiciliosocial. PASEO DE LA CASTELLANA 141 20 - EDIFICIO CUZCO IV (MADRID). Datos registrales. T 26560 , F 220, S 8, H M303693, I/A 28 (21.04.14).
25 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 26560 , F 220, S 8, H M 303693, I/A 27 (17.03.14).
11 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GINES FERRERO OLGA. Nombramientos. Representan: BERMEJO MADERA ALBERTO. Adm.Mancom.: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL;GINES FERRERO OLGA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Administradores mancomunados. Artículo de los estatutos: ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.. Datos registrales. T 26560 , F 109, S 8, H M 303693, I/A 26 ( 4.02.14).
22 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26560 , F 109, S 8, H M 303693, I/A 25 (14.01.14).
07 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26560 , F 109, S 8, H M 303693, I/A 24 (26.11.12).
18 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26560 , F 109, S 8, H M 303693, I/A 23 ( 4.11.11).
22 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: CATENA ASUNSOLO ANGEL. Datos registrales. T 26560 , F 108, S 8, H M 303693, I/A 22(10.06.11).
27 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 26560 , F 108, S 8, H M 303693, I/A 21 (15.12.10).
26 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. C/ EMILIO MUÑOZ, 35 (MADRID). Datos registrales. T 26560 , F 108, S 8, H M 303693, I/A 20(15.04.10).