Actos BORME de Casta Asturias-langreo Sa
23 de Octubre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 112, S 8, H PO 58846, I/A 31 (16.10.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 112, S 8, H PO58846, I/A 30 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 111, S 8, H PO 58846, I/A 29(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 28 (6.06.18).
16 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ FERNANDEZ ALMUDENA;GONZALEZ ABELLA JOSE PEDRO. Datos registrales. T 4204,L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 27 ( 9.03.18).
15 de Marzo de 2018Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 25 ( 2.03.18).
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 26 ( 2.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 24 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 109, S 8, H PO 58846,I/A 21 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A 22(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 110, S 8, H PO 58846, I/A23 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 109, S 8, H PO 58846, I/A 20 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 108, S 8, H PO 58846, I/A 19(25.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 108, S 8, H PO 58846, I/A 18(21.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 107, S 8, H PO 58846, I/A 15 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 107, S 8, H PO 58846, I/A 16 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 107, S 8, H PO 58846, I/A 17 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 107, S 8, H PO 58846, I/A 14(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 73, S 8, H PO 58846, I/A 13(18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 72, S 8, H PO 58846, I/A 11(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 72, S 8, H PO 58846, I/A 12(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 72, S 8, H PO 58846, I/A 10(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 71, S 8, H PO 58846, I/A 9(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 68, S 8, H PO 58846, I/A 8(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 65, S 8, H PO 58846, I/A 7
17 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: ABASCAL CASTA脩ON ALVARO MARIA. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 62, S 8, H PO 58846,I/A 6 ( 5.04.17).
27 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 62, S 8, H PO 58846, I/A 5 (19.01.17).
14 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ ABELLA JOSE PEDRO. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 62, S 8, H PO 58846, I/A 4 (2.10.15).
20 de Agosto de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 4059, L 4059, F 62, S 8, H PO 58846, I/A 3 (12.08.15).
11 de Agosto de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4059, L 4059, F 45, S 8, H PO 58846, I/A 1 (4.08.15).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4059, L 4059, F 62, S 8, H PO 58846, I/A 2 ( 4.08.15).
31 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;GINES FERRERO OLGA. Nombramientos. Adm.Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3707 , F 177, S 8, H AS 36809, I/A 19 (21.07.15).
20 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 29. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 3707 , F 176, S 8, H AS 36809,I/A 18 (11.02.15).
26 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SUAREZ GARCIA JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3707 , F 174, S 8, H AS 36809, I/A 11(17.09.14).
Ceses/Dimisiones. Secretario: VIEJO SASTRE MARA. Consejero: VILLARROYA ALONSO LUIS;CRESPO DE FRANCISCO JOSEMARIA;GINES FERRERO OLGA;SADIM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA. Presidente: VILLARROYA ALONSO LUIS.Con.Delegado: GINES FERRERO OLGA. Nombramientos. SecreNoConsj: GIL-ROBLES CASANUEVA JOSE MARIA.VsecrNoConsj: BARCENA ARTEAGABEITIA RAMON. Vsecr2.NC: CHIQUERO MIELGO VICTOR. Consejero: FERNANDEZMIGUELEZ JOSEFA ISABEL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Datos registrales. T 3707 , F 175, S 8, H AS 36809, I/A 12(17.09.14).
Revocaciones. Apoderado: CRESPO DE FRANCISCO JOSE MARIA;CATENA ASUNSOLO ANGEL. Datos registrales. T 3707 , F175, S 8, H AS 36809, I/A 13 (17.09.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. SecreNoConsj:GIL-ROBLES CASANUEVA JOSE MARIA. VsecrNoConsj: BARCENA ARTEAGABEITIA RAMON. Vsecr2.NC: CHIQUERO MIELGOVICTOR. Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;GINES FERRERO OLGA. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 21. Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culo de los estatutos: 29. Cierre del Ejercicio.-.Datos registrales. T 3707 , F 175, S 8, H AS 36809, I/A 14 (17.09.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL;PENAS GARCIA MARIA JESUS. Datos registrales. T 3707 ,F 175, S 8, H AS 36809, I/A 15 (17.09.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 3707 , F 175, S 8, H AS 36809, I/A 16 (17.09.14).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CASTA SALUD SL. Datos registrales. T 3707 , F 176, S 8, H AS 36809, I/A 17(17.09.14).
01 de Agosto de 2012Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. 1. la promoci贸n y explotaci贸n deun centro sociosanitario en la escombrerade Modesta, Langreo, Asturias. 2. La compra, venta, administraci贸n y arrendamiento deinmueble, bajo cualquier modalidad, as铆 como la contrataci贸n deempresas constructoras y financieras. 3. La prestaci贸n a trav茅s de losprof. Datos registrales. T 3707 , F 174, S 8, H AS 36809, I/A 10 (20.07.12).
12 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: CATENA ASUNSOLO ANGEL. Datos registrales. T 3707 , F 174, S 8, H AS 36809, I/A 8 (29.04.11).
24 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA DE CORROS A LAMOQUINA S/N - CORROS (LANGREO). Datos registrales. T 3707 , F 174, S 8, H AS 36809, I/A 7 (12.03.10).
04 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ABELLA JOSE PEDRO. Datos registrales. T 3707 , F 173, S 8, H AS 36809, I/A 6(21.07.09).