Actos BORME de Casta Valencia Sl
23 de Octubre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 40, S 8, H PO 59029, I/A 26 (16.10.18).
24 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 40, S 8, H PO 59029,I/A 25 (17.07.18).
02 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 39, S 8, H PO 59029, I/A 24(26.06.18).
12 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 39, S 8, H PO 59029, I/A 23 (6.06.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 39, S 8, H PO 59029, I/A 22 (2.03.18).
19 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 38, S 8, H PO 59029, I/A19 (12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 39, S 8, H PO 59029, I/A 20(12.02.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 39, S 8, H PO 59029, I/A21 (12.02.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 37, S 8, H PO 59029, I/A 18 ( 9.02.18).
04 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 37, S 8, H PO 59029, I/A 17(25.08.17).
30 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 37, S 8, H PO 59029, I/A 16(21.08.17).
21 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: BEZARES DIAZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 37, S 8, H PO 59029, I/A 15(10.08.17).
28 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 36, S 8, H PO 59029, I/A 12 (20.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN MARI脩O MARIA;DEL CAMPO REDONDO LUCIA;MELON CASTRO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 4204, L 4204, F 36, S 8, H PO 59029, I/A 13 (24.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;RODRIGUEZ MARTINEZISABEL;PRIEGO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 36, S 8, H PO 59029, I/A 14 (24.07.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ CALAVIA JAVIER. Datos registrales. T 4204, L 4204, F 36, S 8, H PO 59029, I/A 11(19.07.17).
25 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 143, S 8, H PO 59029, I/A 10(18.07.17).
26 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 142, S 8, H PO 59029, I/A 8(16.06.17).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 142, S 8, H PO 59029, I/A 9(19.06.17).
23 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: GALLOFRE PASCUAL ROMAN. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 141, S 8, H PO 59029, I/A 7(15.06.17).
22 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPESINO SOUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 141, S 8, H PO 59029, I/A 6(14.06.17).
21 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 138, S 8, H PO 59029, I/A 5(14.06.17).
20 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 135, S 8, H PO 59029, I/A 4(12.06.17).
30 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 135, S 8, H PO 59029, I/A 3 (21.09.15).
25 de Septiembre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 (VIGO). Datos registrales. T 4067, L 4067, F 120, S 8, H PO 59029, I/A 1(17.09.15).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GINES FERRERO OLGA;FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Nombramientos. Adm.Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 5 de los ESTATUTOSSOCIALES correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T 4067, L 4067, F 135, S 8, H PO 59029, I/A 2 (17.09.15).
22 de Abril de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.040,00 Euros. Datos registrales. T 11130 , F 129, S 8, HM 175270, I/A 15 (15.04.15).
20 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 11130 , F 129, S 8, H M 175270, I/A 14(13.02.15).
13 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Representan: BERMEJO MADERA ALBERTO.Nombramientos. Adm. Mancom.: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL. Datos registrales. T 11130 , F 129, S 8, H M 175270,I/A 13 ( 2.01.15).
24 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: GINES FERRERO OLGA. Datos registrales. T 11130 , F 128, S 8, H M 175270, I/A 12 (13.06.14).
28 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GINES FERRERO OLGA. Nombramientos. Representan: BERMEJO MADERA ALBERTO. Adm.Mancom.: GINES FERRERO OLGA;MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. ARTICULO4.MODIFICADO. Datos registrales. T 11130 , F 126, S 8, H M 175270, I/A 10 (16.04.14).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA-ISABEL;PENAS GARCIA MARIA-JESUS. Cambio de domiciliosocial. PASEO DE LA CASTELLANA 141, PLANTA 20, EDIFICIO C (MADRID). Datos registrales. T 11130 , F 127, S 8, H M175270, I/A 11 (16.04.14).