Actos BORME de Castelo Soluciones Estructurales Sll
15 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: EIRIN BARRIO ANGELES. Secretario: FERREIRA ALVAREZ ELENA. Vicepresid.: BLANCO GABINMANUEL. Consejero: EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO;FERREIRA ALVAREZELENA;ABAD PAREDES DAVID. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n8/01/2014. Auto de apertura de la fase de liquidaci贸n. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez:ROSA LAMA MARRA. Disoluci贸n. Otras Causas. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A B ( 9.12.15).
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/11/2015. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSALAMA MARRA. Extinci贸n. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A 16 ( 9.12.15).
20 de Diciembre de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 4/11/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 242/2013. Fecha de resoluci贸n 4/11/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Administrador Concursal. Fecha 4/11/2013, NIF/CIF35300907R. FERNANDEZ CURRAS FERNANDO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha deresoluci贸n 4/11/2013. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Datos registrales. T3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A A (13.12.13).
05 de Septiembre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 217, S 8, H PO 51758, I/A 15 (28.08.13).
12 de Abril de 2013Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.268.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.416.400,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F216, S 8, H PO 51758, I/A 12 ( 3.04.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIRALDEZ GARCIA JESUS;BABARRO BLANCO MANUEL;OLIVEIRA BARROS FRANCISCOJAVIER;GARCIA LOUREIRO JOSE. Presidente: GIRALDEZ GARCIA JESUS. Vicepresid.: GARCIA LOUREIRO JOSE. Cons.Del.Man:BABARRO BLANCO MANUEL;GARCIA LOUREIRO JOSE. Consejero: EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos.Consejero: EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO;FERREIRA ALVAREZELENA;ABAD PAREDES DAVID. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 13 ( 3.04.13).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Apo.Man.Soli: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Nombramientos.Presidente: EIRIN BARRIO ANGELES. Secretario: FERREIRA ALVAREZ ELENA. Vicepresid.: BLANCO GABIN MANUEL. Apo.Manc.:EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;FERREIRA ALVAREZ ELENA;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO. Apo.Man.Soli:LORENZO MATEO JAIME ALBERTO;FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Apo.Manc.: ABAD PAREDES DAVID. Datos registrales. T3730, L 3730, F 217, S 8, H PO 51758, I/A 14 ( 3.04.13).
14 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRERA PENA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A11 ( 6.03.13).
26 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: LOZANO RODELGO RAQUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 215, S 8, H PO 51758, I/A 9(13.12.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CABADO LOPEZ JOSE LUIS. Cons.Del.Man: VARELA MACEIRA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 10 (13.12.12).
22 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ POUSA JOSE. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 215, S 8, H PO 51758, I/A 8 (9.11.12).
15 de Noviembre de 2012Nombramientos. Consejero: EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES. Ampliaci贸n de capital. Capital: 879.900,00 Euros.Resultante Suscrito: 882.925,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 6 (31.10.12).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 264.850,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.147.775,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F215, S 8, H PO 51758, I/A 7 (31.10.12).
14 de Febrero de 2012Nombramientos. Cons.Del.Man: BABARRO BLANCO MANUEL;GARCIA LOUREIRO JOSE;LOZANO RODELGO RAQUEL;VARELAMACEIRA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 5 (30.01.12).
30 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 213, S 8, H PO 51758,I/A 4 (17.01.12).
24 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Con.Delegado: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO.Secretario: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Consejero: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Presidente: ABRIL BLANCO DANIEL. Consejero:ABRIL BLANCO DANIEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ POUSA JOSE. Consejero: GIRALDEZ GARCIAJESUS;BABARRO BLANCO MANUEL;OLIVEIRA BARROS FRANCISCO JAVIER;GARCIA LOUREIRO JOSE;VARELA MACEIRAJOSE MANUEL;CARRERA PENA JUAN MANUEL;CABADO LOPEZ JOSE LUIS;LOZANO RODELGO RAQUEL. Presidente:GIRALDEZ GARCIA JESUS. Vicepresid.: GARCIA LOUREIRO JOSE. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 212, S 8, H PO 51758, I/A3 (11.10.11).
21 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 212, S 8, H PO 51758, I/A 2 (9.09.11).
05 de Septiembre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.04.11. Objeto social: El desarrollo de actividades de construcci贸n, fabricaci贸n y montajede diversos elementos prefabricados en hormig贸n armado, pretensado y postensado. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL DASGANDARAS S/N (PORRI脩O (O)). Capital: 3.025,00 Euros. Nombramientos. Consejero: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO.Con.Delegado: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Consejero: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Secretario: MILLAN MARTINEZJAVIER. Consejero: ABRIL BLANCO DANIEL. Presidente: ABRIL BLANCO DANIEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 209, S 8, HPO 51758, I/A 1 (23.08.11).