Buscador CIF Logo

Actos BORME Castelo Soluciones Estructurales Sll

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Castelo Soluciones Estructurales Sll

Actos BORME Castelo Soluciones Estructurales Sll - B27758531

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Pontevedra para Castelo Soluciones Estructurales Sll con CIF B27758531

馃敊 Perfil de Castelo Soluciones Estructurales Sll
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Pontevedra

Actos BORME de Castelo Soluciones Estructurales Sll

15 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: EIRIN BARRIO ANGELES. Secretario: FERREIRA ALVAREZ ELENA. Vicepresid.: BLANCO GABINMANUEL. Consejero: EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO;FERREIRA ALVAREZELENA;ABAD PAREDES DAVID. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n8/01/2014. Auto de apertura de la fase de liquidaci贸n. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez:ROSA LAMA MARRA. Disoluci贸n. Otras Causas. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A B ( 9.12.15).

Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/11/2015. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSALAMA MARRA. Extinci贸n. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A 16 ( 9.12.15).

20 de Diciembre de 2013
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 4/11/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 242/2013. Fecha de resoluci贸n 4/11/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Administrador Concursal. Fecha 4/11/2013, NIF/CIF35300907R. FERNANDEZ CURRAS FERNANDO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 242/2013. FIRME: No, Fecha deresoluci贸n 4/11/2013. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n delconcursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE PONTEVEDRA. Juez: ROSA LAMA MARRA. Datos registrales. T3730, L 3730, F 225, S 8, H PO 51758, I/A A (13.12.13).

05 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 217, S 8, H PO 51758, I/A 15 (28.08.13).

12 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.268.625,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.416.400,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F216, S 8, H PO 51758, I/A 12 ( 3.04.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GIRALDEZ GARCIA JESUS;BABARRO BLANCO MANUEL;OLIVEIRA BARROS FRANCISCOJAVIER;GARCIA LOUREIRO JOSE. Presidente: GIRALDEZ GARCIA JESUS. Vicepresid.: GARCIA LOUREIRO JOSE. Cons.Del.Man:BABARRO BLANCO MANUEL;GARCIA LOUREIRO JOSE. Consejero: EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES. Nombramientos.Consejero: EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO;FERREIRA ALVAREZELENA;ABAD PAREDES DAVID. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 13 ( 3.04.13).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Apo.Man.Soli: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Nombramientos.Presidente: EIRIN BARRIO ANGELES. Secretario: FERREIRA ALVAREZ ELENA. Vicepresid.: BLANCO GABIN MANUEL. Apo.Manc.:EIRIN BARRIO ANGELES;BLANCO GABIN MANUEL;FERREIRA ALVAREZ ELENA;PEREZ MINGO JOSE IGNACIO. Apo.Man.Soli:LORENZO MATEO JAIME ALBERTO;FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Apo.Manc.: ABAD PAREDES DAVID. Datos registrales. T3730, L 3730, F 217, S 8, H PO 51758, I/A 14 ( 3.04.13).

14 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRERA PENA JUAN MANUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A11 ( 6.03.13).

26 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: LOZANO RODELGO RAQUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 215, S 8, H PO 51758, I/A 9(13.12.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CABADO LOPEZ JOSE LUIS. Cons.Del.Man: VARELA MACEIRA JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 3730, L 3730, F 216, S 8, H PO 51758, I/A 10 (13.12.12).

22 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREZ POUSA JOSE. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 215, S 8, H PO 51758, I/A 8 (9.11.12).

15 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Consejero: EIRIN BARRIO MARIA DE LOS ANGELES. Ampliaci贸n de capital. Capital: 879.900,00 Euros.Resultante Suscrito: 882.925,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 6 (31.10.12).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 264.850,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.147.775,00 Euros. Datos registrales. T 3730, L 3730, F215, S 8, H PO 51758, I/A 7 (31.10.12).

14 de Febrero de 2012
Nombramientos. Cons.Del.Man: BABARRO BLANCO MANUEL;GARCIA LOUREIRO JOSE;LOZANO RODELGO RAQUEL;VARELAMACEIRA JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 214, S 8, H PO 51758, I/A 5 (30.01.12).

30 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 213, S 8, H PO 51758,I/A 4 (17.01.12).

24 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Con.Delegado: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO.Secretario: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Consejero: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Presidente: ABRIL BLANCO DANIEL. Consejero:ABRIL BLANCO DANIEL. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREZ POUSA JOSE. Consejero: GIRALDEZ GARCIAJESUS;BABARRO BLANCO MANUEL;OLIVEIRA BARROS FRANCISCO JAVIER;GARCIA LOUREIRO JOSE;VARELA MACEIRAJOSE MANUEL;CARRERA PENA JUAN MANUEL;CABADO LOPEZ JOSE LUIS;LOZANO RODELGO RAQUEL. Presidente:GIRALDEZ GARCIA JESUS. Vicepresid.: GARCIA LOUREIRO JOSE. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 212, S 8, H PO 51758, I/A3 (11.10.11).

21 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GIRALDEZ LUIS. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 212, S 8, H PO 51758, I/A 2 (9.09.11).

05 de Septiembre de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.04.11. Objeto social: El desarrollo de actividades de construcci贸n, fabricaci贸n y montajede diversos elementos prefabricados en hormig贸n armado, pretensado y postensado. Domicilio: POLIG INDUSTRIAL DASGANDARAS S/N (PORRI脩O (O)). Capital: 3.025,00 Euros. Nombramientos. Consejero: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO.Con.Delegado: LORENZO MATEO JAIME ALBERTO. Consejero: MILLAN MARTINEZ JAVIER. Secretario: MILLAN MARTINEZJAVIER. Consejero: ABRIL BLANCO DANIEL. Presidente: ABRIL BLANCO DANIEL. Datos registrales. T 3730, L 3730, F 209, S 8, HPO 51758, I/A 1 (23.08.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n