Actos BORME de Castilla Y Leon Sociedad Patrimonial Sa
12 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARCOS GOMEZ GERARDO. Presidente: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER.Consejero: RIBOT GARCIA JOSE MARIA;DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;HERRERO MENDOZA JOSEMANUEL;RUIZ ALONSO CARMEN;BAETA CANALES JOSE ARMANDO;MANZANO MOZO AGUSTIN;NU脩EZ MARTINIRENE;GONZALEZ MANTERO RICARDO ANTONIO. Disoluci贸n. Cesi贸n global de activo y pasivo. Extinci贸n. Datos registrales.T 1501 , F 12, S 8, H VA 22127, I/A 19 ( 5.01.18).
17 de Agosto de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CA.Datos registrales. T 1501 , F 12, S 8, H VA 22127, I/A 18 ( 9.08.17).
03 de Junio de 2016Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 1396 , F 188, S 8, H VA 22127, I/A17 (27.05.16).
19 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: BLANCO GONZALEZ MONICA. Datos registrales. T 1396 , F 188, S 8, H VA 22127, I/A 16(12.02.16).
18 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: LUCAS NAVAS MARIA DEL ROCIO.Consejero: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;LUCAS NAVAS MARIA DEL ROCIO;HERRERO MENDOZA JOSE
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Nombramientos. Presidente: DE ANDRES GUIJARROFRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj: MARCOS GOMEZ GERARDO. Datos registrales. T 1396 , F 188, S 8, H VA 22127, I/A 15(11.02.16).
27 de Marzo de 2014Otros conceptos: Refundici贸n de los Estatutos Sociales, incorporando al texto existente las modificaciones de los art铆culos segundo,cuarto y s茅ptimo acordadas con anterioridad. Cambio de objeto social. a) La gesti贸n y explotaci贸n de los bienes integrantes delpatrimonio de la Comunidad que se le encomiende. b) El dise帽o, el proyecto y la ejecuci贸n de infraestructuras, bienes muebles einmuebles y sus elementos accesorios, y la prestaci贸n de los servicios asociados a los mismos, relacionados con la. Datosregistrales. T 1396 , F 186, S 8, H VA 22127, I/A 13 (20.03.14).
27 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GREDILLA FONTANEDA MARIANO. Datos registrales. T 1396 , F 186, S 8, H VA 22127, I/A 12(20.11.13).
14 de Junio de 2013Nombramientos. Auditor: ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 1396 , F 186, S 8, H VA 22127, I/A 11 (7.06.13).
24 de Mayo de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.273.103,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.269.897,00 Euros. Datos registrales. T 1396, F 186, S 8, H VA 22127, I/A 10 (15.05.12).
21 de Octubre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.647.000,00 Euros. Desembolsado: 1.647.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 38.543.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 36.269.897,00 Euros. Datos registrales. T 1396 , F 185, S 8, H VA 22127, I/A 9 (11.10.11).
28 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;BAETA CANALES JOSE ARMANDO;MANZANOMOZO AGUSTIN;RODRIGUEZ CANTERO MARIA PAZ;BARBADO GARCIA LUIS;DELGADO NU脩EZ RAFAEL;CARNERO GARCIAJESUS JULIO. Vicepresid.: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: DE ANDRES GUIJARROFRANCISCO JAVIER;LUCAS NAVAS MARIA DEL ROCIO;HERRERO MENDOZA JOSE MANUEL;GREDILLA FONTANEDAMARIANO;RUIZ ALONSO CARMEN;BAETA CANALES JOSE ARMANDO;MANZANO MOZO AGUSTIN;VALLE DE JUANA ISABEL.Datos registrales. T 1396 , F 185, S 8, H VA 22127, I/A 7 (19.09.11).
Nombramientos. Presidente: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: LUCAS NAVAS MARIA DEL ROCIO.Datos registrales. T 1396 , F 185, S 8, H VA 22127, I/A 8 (19.09.11).
28 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL OLMO MORO MARIA DEL PILAR. Presidente: DEL OLMO MORO MARIA DEL PILAR. Datosregistrales. T 1353 , F 34, S 8, H VA 22127, I/A 6 (16.06.11).
01 de Marzo de 2011Otros conceptos: Refundici贸n de los Estatutos Sociales, incorporando al texto existente las modificaciones del art铆culo 2 y delart铆culo7. Cambio de objeto social. a) La gesti贸n y explotaci贸n de los bienes integrantes del patrimonio de laComunidad que se leencomiende. b) El dise帽o, el proyecto y la ejecuci贸n de infraestructuras y bienes inmuebles y de los servicios asociados a los mismos,relacionados con la gesti贸n del patrimonio de la Comunidad, para lo cu. Datos registrales. T 1353 , F 33, S 8, H VA 22127, I/A 5(18.02.11).
09 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 13.496.000,00 Euros. Desembolsado: 11.222.897,00 Euros. Resultante Suscrito: 36.896.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 34.622.897,00 Euros. Datos registrales. T 1353 , F 32, S 8, H VA 22127, I/A 4 (26.02.10).
17 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: MARCOS GOMEZ GERARDO. Datos registrales. T 1353 , F 31, S 8, H VA 22127, I/A 3 ( 6.04.09).
31 de Marzo de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 10.03.09. Objeto social: a) La gesti贸n y explotaci贸n de los bienes integrantes del patrimoniode laComunidad que se le encomiende. b) El dise帽o, el proyecto y la ejecuci贸n de infraestructuras y bienes inmuebles y de losservicios asociados a los mismos, relacionados con la gesti贸n del patrimonio de la Comunidad. c) La gest. Domicilio: C/ JOSECANTALAPIEDRA 2 (VALLADOLID). Capital suscrito: 23.400.000,00 Euros. Desembolsado: 23.400.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. Nombramientos. Consejero: DEL OLMOMORO MARIA DEL PILAR;DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER;BAETA CANALES JOSE ARMANDO;MANZANO MOZOAGUSTIN;RODRIGUEZ CANTERO PAZ;BARBADO GARCIA LUIS;DELGADO NU脩EZ RAFAEL;CARNERO GARCIA JESUS JULIO.Datos registrales. T 1353 , F 29, S 8, H VA 22127, I/A 1 (20.03.09).
Nombramientos. Presidente: DEL OLMO MORO MARIA DEL PILAR. Vicepresid.: DE ANDRES GUIJARRO FRANCISCO JAVIER.SecreNoConsj: RODRIGUEZ SANZ-PASTOR JOSE. Datos registrales. T 1353 , F 31, S 8, H VA 22127, I/A 2 (20.03.09).