Actos BORME de Castillo Aresan Sociedad Limitada
19 de Julio de 2021Revocaciones. Apoderado: MUÑOZ DE LA CRUZ ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 1000, L 764, F 126, S 8, H AB 26316,I/A 10 ( 9.07.21).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MONTOLIU DAVID. Datos registrales. T 1000, L 764, F 126, S 8, H AB 26316, I/A 11 (9.07.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BERZOSA IRENE. Datos registrales. T 1000, L 764, F 126, S 8, H AB 26316, I/A 12 (9.07.21).
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ DE LA CRUZ ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 1034, L 798, F 165, S 8, H AB 26316,I/A 13 ( 9.07.21).
08 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: BONFILS JEAN MICHEL JOSEPH. Datos registrales. T 1000, L 764, F 126, S 8, H AB 26316, I/A 8 (1.07.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: BONFILS JEROME. Datos registrales. T 1000, L 764, F 126, S 8, H AB 26316, I/A 9 ( 1.07.21).
20 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: GARCIA MONTOLIU DAVID. Datos registrales. T 986, L 750, F 64, S 8, H AB 26316, I/A 5 (13.12.18).
Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ DE LA CRUZ ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 986, L 750, F 64, S 8, H AB 26316,I/A 6 (13.12.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: PAYA I TODOLI ISRAEL;DOMINGO RUBI FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 1000, L 764, F 124,S 8, H AB 26316, I/A 7 (13.12.18).
13 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: PAYA I TODOLI ISRAEL;GIL FUSALBA ANGEL. Apoderado: FERNANDEZ QUEROL VERONICA. Datosregistrales. T 986, L 750, F 63, S 8, H AB 26316, I/A 3 ( 6.09.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PAYA I TODOLI ISRAEL;DOMINGO RUBI FRANCESC XAVIER. Datos registrales. T 986, L 750, F 64,S 8, H AB 26316, I/A 4 ( 6.09.17).