Actos BORME de Castillo De Luzon Sl
07 de Febrero de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 57.635,90 Euros. Resultante Suscrito: 99.705,90 Euros. Datos registrales. T 2140 , F 133, S 8, HMU 48204, I/A 6 (31.01.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JUAN JOSE MARTINEZ ABELLAN;PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA.Nombramientos. Adm. Mancom.: JAVIER MIGUEL MARTINEZ GIL;ALVARO LUIS MARTINEZ GIL. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. MODIFICAN EL APARTADO 3 DELARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 2140 , F 135, S 8, H MU 48204, I/A 7 (31.01.20).
Nombramientos. Apoderado: JAVIER MIGUEL MARTINEZ GIL. Datos registrales. T 3429 , F 88, S 8, H MU 48204, I/A 8(31.01.20).
25 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: AMANCIO ALFOCEA MOLINA;AMANCIO ALFOCEA ZAMORA;JUAN JOSE MARTINEZABELLAN;PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA. Presidente: AMANCIO ALFOCEA MOLINA. Vicepresid.: PASCUALA MARIADEL ROSARIO GIL VERA. Secretario: JUAN JOSE MARTINEZ ABELLAN. Vicesecret.: AMANCIO ALFOCEA ZAMORA. Cons.Del.Sol:JUAN JOSE MARTINEZ ABELLAN;AMANCIO ALFOCEA MOLINA. Cons.Del.Man: AMANCIO ALFOCEA MOLINA;JUAN JOSEMARTINEZ ABELLAN. Nombramientos. Adm. Solid.: JUAN JOSE MARTINEZ ABELLAN;PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GILVERA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios.Cambio de domicilio social. CTRA DE JUMILLA-ONTUR Km 4,5 (JUMILLA). Datos registrales. T 2140 , F 132, S 8, H MU 48204,I/A 4 (17.04.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: FRANCISCO CLIMENT PEREZ;PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA. Datos registrales. T 2140, F 133, S 8, H MU 48204, I/A 5 (17.04.12).
26 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: FRANCISCO CLIMENT PEREZ;PASCUALA MARIA DEL ROSARIO GIL VERA. Datos registrales. T2140 , F 132, S 8, H MU 48204, I/A 3 (17.03.10).