Actos BORME de Castolin Iberica Sl
26 de Mayo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE. Apo.Manc.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE. Apo.Sol.: JERONIMO MATEYPATRICIA;MARTIN MARTIN GERMAN. Apoderado: JERONIMO MATEY PATRICIA;MARTIN MARTIN GERMAN. Nombramientos.Apo.Manc.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE. Apo.Sol.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE;JERONIMO MATEY PATRICIA. Apo.Manc.:JERONIMO MATEY PATRICIA;MARTIN MARTIN GERMAN. Apo.Sol.: MARTIN MARTIN GERMAN. Datos registrales. T 35280 , F211, S 8, H M 361324, I/A 28 (19.05.23).
09 de Junio de 2022Nombramientos. R.C.P.SolMan: HERNANDEZ GOMEZ JOSE;MERINO MARTINEZ BEATRIZ;FERREIRA DIAZ FRANCISCO JOSE.Otros conceptos: Cesados don JOSE PECIÑA SANCHEZ y don ANGEL NOVO BRICIO como representantes directores de lasucursal "CASTOLIN IBERICA SL SUCURSAL EN PORTUGAL". Datos registrales. T 35280 , F 210, S 8, H M 361324, I/A 26 (2.06.22).
Ceses/Dimisiones. R.C.P.SolMan: FERREIRA DIAZ FRANCISCO JOSE;MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Nombramientos.R.C.P.SolMan: JERONIMO MATEY PATRICIA;MARTIN MARTIN GERMAN. Otros conceptos: Cambiado el domicilio de la Sucursalen Portugal, a LAGO DE ANDALUZ, 15-2D, FREGUESIA DE SANTO ANTONIO, 1050-168 LISBOA. Datos registrales. T 35280 , F210, S 8, H M 361324, I/A 27 ( 2.06.22).
29 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: PECIÑA SANCHEZ JOSE;NOVO BRICIO ANGEL;MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Datos registrales. T35280 , F 209, S 8, H M 361324, I/A 25 (22.09.21).
17 de Febrero de 2021Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35280 , F209, S 8, H M 361324, I/A 24 (10.02.21).
29 de Junio de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CASTOLIN EUTECTIC GMBH. Datos registrales. T 35280 , F 209,S 8, H M 361324, I/A 23 (22.06.20).
30 de Diciembre de 2019Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35280 , F 209, S 8, H M 361324, I/A 22 (21.12.19).
24 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: HOPFENBACH FRANK MANFRED FRANZISKUS. Vicepresid.: HOPFENBACH FRANK MANFREDFRANZISKUS. Consejero: MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Revocaciones. Apo.Sol.: MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Apo.Manc.:MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Nombramientos. Consejero: KIRCHGASSNER MARTIN;DELARBOULAS OLIVIER CHRISTOPHE.Vicepresid.: KIRCHGASSNER MARTIN. Otros conceptos: Sujeto Revocado : MERINO MARTINEZ BEATRIZ Cargo o Función :Apoderada Fecha de revocación : 29/03/2019 NIF/CIF: 00833247A. Datos registrales. T 35280 , F 208, S 8, H M 361324, I/A 21(17.12.19).
04 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ROMO ANGEL LUIS. Nombramientos. Apoderado: JERONIMO MATEY PATRICIA;MARTINMARTIN GERMAN. Otros conceptos: Ratificados y ampliados los poderes conferidos a Doña Patricia Jerónimo Matey y DonGermán Martín Martín mediante escritura que originó la inscripción 17ª. Datos registrales. T 35280 , F 207, S 8, H M 361324, I/A 20(26.11.18).
12 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: MERINO MARTINEZ BEATRIZ;HERNANDEZ GOMEZ JOSE. Datos registrales. T 35280 , F 207, S 8,H M 361324, I/A 19 ( 5.05.17).
13 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHABEL SIEGFRIED;SCHMITZ WERNER;KIRCHGASSNER MARTIN. Presidente:KIRCHGASSNER MARTIN. Nombramientos. Consejero: MERINO MARTINEZ BEATRIZ;MARTIN VINCENTMICHEL;HOPFENBACH FRANK MANFRED FRANZISKUS. Presidente: MARTIN VINCENT MICHEL. Vicepresid.: HOPFENBACHFRANK MANFRED FRANZISKUS. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 35280 , F 206, S 8, H M361324, I/A 18 ( 3.02.17).
29 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: PECIÑA SANCHEZ JOSE;NOVO BRICIO ANGEL;ALFARO ARRIBAS JUAN. Nombramientos.Apo.Sol.: MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: MERINO MARTINEZ BEATRIZ. Apo.Sol.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE.Apo.Manc.: HERNANDEZ GOMEZ JOSE. Apo.Sol.: JERONIMO MATEY PATRICIA;MARTIN MARTIN GERMAN. Datos registrales. T20428 , F 225, S 8, H M 361324, I/A 17 (21.11.16).
12 de Agosto de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20428 , F 225, S 8, H M 361324, I/A 16 ( 4.08.14).
25 de Febrero de 2014Ampliación de capital. Capital: 994.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.000.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 20428 , F 224, S 8, H M 361324, I/A 15 (17.02.14).
28 de Enero de 2014Otros conceptos: El Socio Unico de la Sociedad, de nacionalidad alemana, ha cambiado su denominación social, hasta ahora,"Messe Cutting & Welding Gmbh" por la de "Messer Cutting Systems Gmbh", con NIF en España número N0049785I.- Datosregistrales. T 20428 , F 223, S 8, H M 361324, I/A 14 (20.01.14).
05 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ROAKE ANDREW FLETCHER. Presidente: ROAKE ANDREW FLETCHER. Nombramientos.Consejero: KIRCHGASSNER MARTIN. Presidente: KIRCHGASSNER MARTIN. Datos registrales. T 20428 , F 222, S 8, H M 361324,I/A 12 (24.05.12).
Nombramientos. Apoderado: NOVO BRICIO ANGEL;PECIÑA SANCHEZ JOSE. Datos registrales. T 20428 , F 222, S 8, H M361324, I/A 13 (25.05.12).
16 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 20428 , F 222, S 8, H M 361324, I/A 11 ( 6.03.12).
25 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ROMO ANGEL LUIS;NOVO BRICIO ANGEL;PECIÑA SANCHEZ JOSE;ALFARO ARRIBASJUAN. Datos registrales. T 20428 , F 221, S 8, H M 361324, I/A 10 (16.11.11).