Actos BORME de Catebing Sureste Sociedad Anonima
03 de Mayo de 2023Nombramientos. Apoderado: MORENO GARCIA NURIA. Datos registrales. T 3795 , F 186, S 8, H A 24089, I/A 23 (21.04.23).
22 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Secretario: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Nombramientos.Consejero: COVES SELVA GASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Datos registrales. T 3795 , F 185, S 8, H A 24089, I/A22 (15.07.22).
03 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: COVES SELVA GASPAR. Datos registrales. T 3795 , F 185, S 8, H A 24089, I/A 21 (25.10.21).
10 de Agosto de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: COVES SELVA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero: COVES SELVAGASPAR. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Nombramientos. Consejero: PIQUERES LOPEZ DOLORES. Secretario:PIQUERES LOPEZ DOLORES. Datos registrales. T 3795 , F 185, S 8, H A 24089, I/A 20 ( 2.08.21).
24 de Agosto de 2020Modificación de poderes. Apo.Sol.: ADSUAR LLEDO JUAN RAMON. Datos registrales. T 3795 , F 185, S 8, H A 24089, I/A 19(13.08.20).
18 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: COVES COVES ASUNCION. Datos registrales. T 3675 , F 149, S 8, H A 24089, I/A 18 ( 6.08.20).
05 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: SALA DOLO SERGIO. Datos registrales. T 3675 , F 148, S 8, H A 24089, I/A 17 (27.11.19).
10 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: RUBI MONTES JAIME. Datos registrales. T 3675 , F 68, S 8, H A 24089, I/A 16 ( 2.04.19).
27 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA. Nombramientos. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA.Reelecciones. Consejero: COVES SELVA JOSE MARIA;COVES SELVA GASPAR;COVES SELVA VICENTE. Presidente: COVESSELVA VICENTE. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Datos registrales. T 3675 , F 68, S 8, H A 24089, I/A 15 (18.03.19).
22 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Apo.Sol.: DURA BROTONS MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3675 , F 68, S 8, H A 24089, I/A 14(14.06.18).
27 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: DURA BROTONS MIGUEL ANGEL;COVES COVES VICENTE;COVES PIQUERES GASPAR;ADSUARLLEDO JUAN RAMON;RUIZ SAEZ ANGEL;COVES COVES ASUNCION;CARRATALA ASENSI ASTRID MARIA. Datos registrales. T3675 , F 66, S 8, H A 24089, I/A 13 (19.06.17).
01 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: COVES SELVA JOSE MARIA;COVES SELVA GASPAR;COVES SELVA VICENTE. Presidente:COVES SELVA JOSE MARIA. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Con.Delegado: COVES SELVA VICENTE. Nombramientos.Apoderado: COVES SELVA VICENTE. Consejero: COVES SELVA JOSE MARIA;COVES SELVA GASPAR;COVES SELVA VICENTE.Presidente: COVES SELVA VICENTE. Secretario: COVES SELVA GASPAR. Con.Delegado: COVES SELVA JOSE MARIA. Datosregistrales. T 1651 , F 110, S 8, H A 24089, I/A 12 (20.03.13).
17 de Septiembre de 2010Modificaciones estatutarias. Artículo 29º.- Remuneración del cargo de administrador. Artículo 31º.- Composición del Consejo. Otrosconceptos: Artículo 27º.- Plazo del cargo de administrador. Datos registrales. T 1651 , F 110, S 8, H A 24089, I/A 11 ( 7.09.10).