Buscador CIF Logo

Actos BORME Catespan Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Catespan Sa

Actos BORME Catespan Sa - A62646617

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Catespan Sa con CIF A62646617

馃敊 Perfil de Catespan Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Catespan Sa

21 de Julio de 2023
Nombramientos. Auditor: COUSO Y RUANO AUDITORES SLP. Reelecciones. Consejero: GRI脩O CRISTIA JORDI. Presidente:GRI脩O CRISTIA JORDI. Datos registrales. T 37689 , F 27, S 8, H M 671503, I/A 9 (14.07.23).

Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 11 bis. Datos registrales. T 37689 , F 27, S 8, H M 671503, I/A 10 (15.07.23).

27 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: ZUKS KONSTANTINS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITO GONZALO.Datos registrales. T 37689 , F 26, S 8, H M 671503, I/A 8 (20.10.21).

01 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO. Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARISCAL JESUS.Nombramientos. Consejero: GUILLEN VELASCO ARMANDO. Con.Delegado: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datosregistrales. T 37689 , F 25, S 8, H M 671503, I/A 7 (25.08.21).

20 de Octubre de 2020
Nombramientos. Consejero: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Secretario: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datosregistrales. T 37689 , F 24, S 8, H M 671503, I/A 5 (13.10.20).

Nombramientos. Apoderado: ROMERO PAJARES ALFREDO;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITOGONZALO. Datos registrales. T 37689 , F 24, S 8, H M 671503, I/A 6 (13.10.20).

26 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: EXPOSITO CABANILLAS MARIA GUADALUPE;PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLASCRISTINA. Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITOGONZALO. Datos registrales. T 37689 , F 23, S 8, H M 671503, I/A 4 (19.11.19).

06 de Julio de 2018
Nombramientos. Auditor: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Reelecciones. Consejero: GRI脩O CRISTIA JORDI. Presidente: GRI脩OCRISTIA JORDI. Datos registrales. T 37689 , F 23, S 8, H M 671503, I/A 3 (27.06.18).

23 de Mayo de 2018
Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FLEMING 36 - ENTREPLANTA IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 37689 , F23, S 8, H M 671503, I/A 2 (16.05.18).

21 de Junio de 2017
Revocaciones. SECR.NO CONS: FERRER PUIG CARLOS. Nombramientos. SECRETARIO: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA.Otros conceptos: DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD"DESARROLLOS ALIMENTARIOS, SA". Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B 235803, I/A 36 (14.06.17).

30 de Agosto de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO. Nombramientos.CONSEJERO: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B235803, I/A 35 (22.08.16).

19 de Agosto de 2015
Revocaciones. APODERADO: PEREZ MARISCAL JESUS;LEAN CABANILLAS JAVIER. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, HB 235803, I/A 34 (11.08.15).

30 de Julio de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL.CONSEJERO: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B 235803, I/A 33 (22.07.15).

22 de Junio de 2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: MITJANA SOLE ENRIQUE. Datos registrales. T 38407 , F 172, S 8, HB 235803, I/A 15 N ( 9.06.15).

28 de Abril de 2015
Revocaciones. APODERADO: LEAN CABANILLAS FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. APOD.MANCOMU: EXPOSITOCABANILLAS MARIA GUADALUPE;PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 39052 , F212, S 8, H B 235803, I/A 32 (20.04.15).

04 de Agosto de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.003,00 Euros. Desembolsado: 400.003,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.505.593,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.505.593,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 31 (25.07.14).

29 de Julio de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: GRI脩O CRISTIA JORDI. PRESIDENTE: GRI脩O CRISTIA JORDI. Nombramientos. CONSEJERO:GRI脩O CRISTIA JORDI. PRESIDENTE: GRI脩O CRISTIA JORDI. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 459.990,00 Euros.Desembolsado: 459.990,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.105.590,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.105.590,00 Euros. Datosregistrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 30 (18.07.13).

13 de Junio de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 29 (6.06.13).

08 de Enero de 2013
Cambio de domicilio social. CL ROMA Num.5 (RUBI). Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 28 (27.12.12).

25 de Agosto de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER;EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO.Nombramientos. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER;EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO.Datos registrales. T 38407 , F 179, S 8, H B 235803, I/A 27 (11.08.11).

24 de Junio de 2011
Revocaciones. APODERADO: MITJANA SOLE ENRIQUE. Nombramientos. APODERADO: PEREZ MARISCAL JESUS;LEANCABANILLAS FRANCISCO JAVIER;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 38407 , F 178, S 8, H B 235803, I/A26 (14.06.11).

24 de Diciembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 38407 , F 178, S 8, H B 235803, I/A 25(15.12.09).

03 de Febrero de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 770.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 645.600,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F177, S 8, H B 235803, I/A 24 (22.01.09).

23 de Enero de 2009
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 118.000,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F 177, S 8, H B 235803, I/A23 (13.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n