Actos BORME de Catespan Sa
21 de Julio de 2023Nombramientos. Auditor: COUSO Y RUANO AUDITORES SLP. Reelecciones. Consejero: GRI脩O CRISTIA JORDI. Presidente:GRI脩O CRISTIA JORDI. Datos registrales. T 37689 , F 27, S 8, H M 671503, I/A 9 (14.07.23).
Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 11 bis. Datos registrales. T 37689 , F 27, S 8, H M 671503, I/A 10 (15.07.23).
27 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: ZUKS KONSTANTINS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITO GONZALO.Datos registrales. T 37689 , F 26, S 8, H M 671503, I/A 8 (20.10.21).
01 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO. Revocaciones. Apoderado: PEREZ MARISCAL JESUS.Nombramientos. Consejero: GUILLEN VELASCO ARMANDO. Con.Delegado: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datosregistrales. T 37689 , F 25, S 8, H M 671503, I/A 7 (25.08.21).
20 de Octubre de 2020Nombramientos. Consejero: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Secretario: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datosregistrales. T 37689 , F 24, S 8, H M 671503, I/A 5 (13.10.20).
Nombramientos. Apoderado: ROMERO PAJARES ALFREDO;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITOGONZALO. Datos registrales. T 37689 , F 24, S 8, H M 671503, I/A 6 (13.10.20).
26 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: EXPOSITO CABANILLAS MARIA GUADALUPE;PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLASCRISTINA. Nombramientos. Apoderado: PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA;FERNANDEZ EXPOSITOGONZALO. Datos registrales. T 37689 , F 23, S 8, H M 671503, I/A 4 (19.11.19).
06 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Reelecciones. Consejero: GRI脩O CRISTIA JORDI. Presidente: GRI脩OCRISTIA JORDI. Datos registrales. T 37689 , F 23, S 8, H M 671503, I/A 3 (27.06.18).
23 de Mayo de 2018Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR FLEMING 36 - ENTREPLANTA IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 37689 , F23, S 8, H M 671503, I/A 2 (16.05.18).
21 de Junio de 2017Revocaciones. SECR.NO CONS: FERRER PUIG CARLOS. Nombramientos. SECRETARIO: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA.Otros conceptos: DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO LA SOCIEDAD"DESARROLLOS ALIMENTARIOS, SA". Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B 235803, I/A 36 (14.06.17).
30 de Agosto de 2016Revocaciones. CONSEJERO: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO. Nombramientos.CONSEJERO: EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B235803, I/A 35 (22.08.16).
19 de Agosto de 2015Revocaciones. APODERADO: PEREZ MARISCAL JESUS;LEAN CABANILLAS JAVIER. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, HB 235803, I/A 34 (11.08.15).
30 de Julio de 2015Revocaciones. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL.CONSEJERO: EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 39052 , F 213, S 8, H B 235803, I/A 33 (22.07.15).
22 de Junio de 2015Cancelaciones de oficio de nombramientos. CONSEJERO: MITJANA SOLE ENRIQUE. Datos registrales. T 38407 , F 172, S 8, HB 235803, I/A 15 N ( 9.06.15).
28 de Abril de 2015Revocaciones. APODERADO: LEAN CABANILLAS FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. APOD.MANCOMU: EXPOSITOCABANILLAS MARIA GUADALUPE;PEREZ MARISCAL JESUS;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 39052 , F212, S 8, H B 235803, I/A 32 (20.04.15).
04 de Agosto de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 400.003,00 Euros. Desembolsado: 400.003,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.505.593,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.505.593,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 31 (25.07.14).
29 de Julio de 2013Revocaciones. CONSEJERO: GRI脩O CRISTIA JORDI. PRESIDENTE: GRI脩O CRISTIA JORDI. Nombramientos. CONSEJERO:GRI脩O CRISTIA JORDI. PRESIDENTE: GRI脩O CRISTIA JORDI. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 459.990,00 Euros.Desembolsado: 459.990,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.105.590,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.105.590,00 Euros. Datosregistrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 30 (18.07.13).
13 de Junio de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 29 (6.06.13).
08 de Enero de 2013Cambio de domicilio social. CL ROMA Num.5 (RUBI). Datos registrales. T 38407 , F 180, S 8, H B 235803, I/A 28 (27.12.12).
25 de Agosto de 2011Revocaciones. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER;EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO.Nombramientos. CONSEJERO: LEAN CABANILLAS JAVIER;EXPOSITO HERNANDEZ LEONCIO;GUILLEN VELASCO ARMANDO.Datos registrales. T 38407 , F 179, S 8, H B 235803, I/A 27 (11.08.11).
24 de Junio de 2011Revocaciones. APODERADO: MITJANA SOLE ENRIQUE. Nombramientos. APODERADO: PEREZ MARISCAL JESUS;LEANCABANILLAS FRANCISCO JAVIER;EXPOSITO CABANILLAS CRISTINA. Datos registrales. T 38407 , F 178, S 8, H B 235803, I/A26 (14.06.11).
24 de Diciembre de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: VAHN Y CIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 38407 , F 178, S 8, H B 235803, I/A 25(15.12.09).
03 de Febrero de 2009Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 770.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 645.600,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F177, S 8, H B 235803, I/A 24 (22.01.09).
23 de Enero de 2009Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 118.000,00 Euros. Datos registrales. T 38407 , F 177, S 8, H B 235803, I/A23 (13.01.09).