Actos BORME de Cavalier Directorship Sl
04 de Mayo de 2023Modificaciones estatutarias. INTRODUCCION DEL ARTICULO 6 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T41411 , F 110, S 8, H M 676116, I/A 16 (25.04.23).
28 de Octubre de 2022Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GANDASOLAR 17 SL. Datos registrales. T 41411 , F 110, S 8, H M676116, I/A 15 (21.10.22).
26 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: PENTREATH NICHOLAS;MARTINEZNAVARRO MARIA ARANZAZU;DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;TIELVE MARTINEZ DE GUERE脩U BEATRIZ;LACACI NUEVOFERNANDO;MOLINARI MIRKO PIETRO EMILIO;MOLINA DEL VALLE ELENA;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE;MOYATRIGUERO FRANCISCO. Datos registrales. T 41411 , F 107, S 8, H M 676116, I/A 14 (19.04.22).
05 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 41411 , F 105, S 8, H M 676116, I/A 13(27.04.21).
29 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU. Datos registrales. T 37972 , F 10, S 8, H M 676116, I/A12 (22.04.21).
05 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: DIAZ ALMAZAN DAVID ANTONIO;MICO VALDENEBRO FERNANDO;DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;TIELVE MARTINEZ DE GUERE脩U BEATRIZ;LACACI NUEVO FERNANDO;RIBALLO FERNANDEZANTONIO ENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T37972 , F 6, S 8, H M 676116, I/A 7 (28.09.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ-CONDE ALARCON LAURA. Datos registrales. T 37972 , F 9, S 8, H M 676116, I/A 8(28.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PASQUIN RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 37972 , F 9, S 8, H M 676116, I/A 9(28.09.20).
Revocaciones. Apoderado: PARADISO BENIAMINO;PARADISO BENIAMINO. Datos registrales. T 37972 , F 9, S 8, H M 676116,I/A 10 (28.09.20).
Revocaciones. Apoderado: MICO VALDENEBRO FERNANDO. Datos registrales. T 37972 , F 10, S 8, H M 676116, I/A 11(28.09.20).
30 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Nombramientos. Representan: NOGUERA PUJOL-XICOY LLUIS.Datos registrales. T 37972 , F 6, S 8, H M 676116, I/A 6 (23.04.20).
27 de Abril de 2020Cambio de domicilio social. C/ POETA JOAN MARAGALL N潞 1, 5陋 PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 37972 , F 6, S 8, H M676116, I/A 5 (20.04.20).
29 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: DE LA SERNA GOULD LUIS-JAIME;PARADISO BENIAMINO;RIBALLO FERNANDEZ ANTONIOENRIQUE;MARTINEZ NAVARRO MARIA ARANZAZU;DOMINGUEZ BAYON LORETO. Datos registrales. T 37972 , F 4, S 8, H M676116, I/A 4 (22.05.19).
05 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELES SL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO.Nombramientos. Adm. Unico: X-ELIO ENERGY SL. Representan: BARREDO LOPEZ JORGE. Cambio de domicilio social. C/
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: X-ELIO ENERGY SL. Datos registrales. T 37972 , F 4, S 8, H M 676116, I/A 3(26.10.18).
27 de Julio de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 13.07.18. Objeto social: El asesoramiento y consultor铆a en general de toda clase deempresas, especialmente en los campos fiscal, contable, laboral, econ贸mico, multimedia, internet, servicios, en cuyo caso la sociedadactuar谩 como sociedad de medios o de intermediaci贸n. La actividad inmobiliaria y la urbanizaci贸n, etc. Domicilio: C/ MONTEESQUINZA 30 - BAJO IZQUIERDA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: DIRECTORSHIP CIBELESSL. Representan: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO. Datos registrales. T 37972 , F 1, S 8, H M 676116, I/A 1 (20.07.18).