Buscador CIF Logo

Actos BORME Cavas Conde De Caralt Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cavas Conde De Caralt Sa

Actos BORME Cavas Conde De Caralt Sa - A08154957

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Cavas Conde De Caralt Sa con CIF A08154957

馃敊 Perfil de Cavas Conde De Caralt Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Cavas Conde De Caralt Sa

09 de Mayo de 2019
Extinci贸n. Datos registrales. T 46566 , F 122, S 8, H B 46256, I/A 80 ( 2.05.19).

09 de Octubre de 2018
Nombramientos. APOD.MANCOMU: FERRER NOGUER PEDRO;THOMAS MANFRED SCHOLL;BERND FRIEDRICH KURTHALBACH;MARIMON PRATS ANTONIO;AZCUNE ELORZA NEREA LEONOR. Datos registrales. T 31789 , F 124, S 8, H B 46256,I/A 79 ( 2.10.18).

13 de Septiembre de 2018
Revocaciones. APODERADO: HEVIA FERRER ENRIQUE JOSE. Nombramientos. APODERAD.SOL: ANTONIO MARIMONPRATS;AZCUNE ELORZA NEREA LEONOR. Datos registrales. T 31789 , F 124, S 8, H B 46256, I/A 78 ( 6.09.18).

07 de Septiembre de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: FERRER SALA JOSE;BONET FERRER JOSE LUIS;FERRER NOGUER PEDRO;HEVIA FERRERENRIQUE JOSE;BONET FERRER PEDRO;BONET FERRER EUDALDO;FERRER NOGUER JOSE MARIA;FERRER NOGUERMERCEDES. VICESECRET.: FERRER NOGUER MERCEDES. PRESIDENTE: BONET FERRER JOSE LUIS. SECRETARIO:FERRER NOGUER JOSE MARIA. CONS. DELEG.: FERRER NOGUER PEDRO. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: FERRERNOGUER PEDRO;THOMAS MANFRED SCHOLL. Modificaciones estatutarias. ARTS.14,25,26 Y 27(SIN CONTENIDO).-CAMBIODE REGIMEN ADMINISTRATIVO.ART.28.-FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 31789 , F 123, S 8, H B 46256, I/A 77(31.08.18).

29 de Agosto de 2018
Nombramientos. APOD.MANCOMU: FERRER NOGUER PEDRO;SANCHEZ LOMBARTE ANSELM. Datos registrales. T 31789 , F123, S 8, H B 46256, I/A 76 (17.08.18).

26 de Agosto de 2014
Nombramientos. CONSEJERO: FERRER SALA JOSE;BONET FERRER JOSE LUIS;FERRER NOGUER PEDRO;HEVIA FERRERENRIQUE JOSE;BONET FERRER PEDRO;BONET FERRER EUDALDO;FERRER NOGUER JOSE MARIA;FERRER NOGUERMERCEDES. VICESECRET.: FERRER NOGUER MERCEDES. PRESIDENTE: BONET FERRER JOSE LUIS. SECRETARIO:FERRER NOGUER JOSE MARIA. CONS. DELEG.: FERRER NOGUER PEDRO. Modificaciones estatutarias. ART.27:ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 31789 , F 122, S 8, H B 46256, I/A 75(19.08.14).

22 de Mayo de 2014
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ABEL LLUCH JOSE LUIS. Datos registrales. T 31789 , F 121, S 8, H B 46256, I/A 74(15.05.14).

17 de Noviembre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31789 , F 121, S 8, H B 46256, I/A 73 (3.11.10).

05 de Noviembre de 2009
Nombramientos. CONSEJERO: FERRER SALA JOSE;BONET FERRER JOSE LUIS. PRESIDENTE: BONET FERRER JOSE LUIS.CONSEJERO: FERRER NOGUER PEDRO. CONS. DELEG.: FERRER NOGUER PEDRO. CONSEJERO: HEVIA FERRER ENRIQUEJOSE;BONET FERRER PEDRO;BONET FERRER EUDALDO;FERRER NOGUER JOSE MARIA. SECRETARIO: FERRER NOGUERJOSE MARIA. Datos registrales. T 31789 , F 120, S 8, H B 46256, I/A 72 (27.10.09).

15 de Octubre de 2009
Nombramientos. APODERADO: PALAU CASELLAS JOSEP. Datos registrales. T 31789 , F 120, S 8, H B 46256, I/A 71 ( 2.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n