Actos BORME de Cecauto Centro Sa
26 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: PUJADO MENDEZ ANTONIO. Presidente: PUJADO MENDEZ ANTONIO. Consejero: GORGE RIERAPABLO VICENTE;LUCAS GONZALEZ JESUS;CUETO MARTIN JUAN CARLOS. SecreNoConsj: SANCHEZ CATALA PABLO.Revocaciones. Apoderado: LUCAS GONZALEZ JESUS. Otros conceptos: A los efectos del Artículo 233.2, 2º párrafo, quedacancelada la sociedad por haber sido absorbida la sociedad por la entidad domiciliada en Valencia CECAUTO LOGISTICA SL, ypracticada la inscripción en dicho Registro Mercantil de valenciaen fecha 27 de Marzo de 2013. Extinción. Datos registrales. T27674 , F 11, S 8, H M 119279, I/A 24 (18.04.13).
25 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PUJADO MENDEZ ANTONIO;GORGE RIERA PABLO VICENTE;LUCAS GONZALEZJESUS;GIMENEZ SOTOCA MANUEL;CUETO MARTIN JUAN CARLOS. Presidente: PUJADO MENDEZ ANTONIO. Secretario:SANCHEZ CATALA PABLO. Nombramientos. Consejero: PUJADO MENDEZ ANTONIO. Presidente: PUJADO MENDEZ ANTONIO.Consejero: GORGE RIERA PABLO VICENTE;LUCAS GONZALEZ JESUS;CUETO MARTIN JUAN CARLOS. SecreNoConsj:SANCHEZ CATALA PABLO. Datos registrales. T 27674 , F 11, S 8, H M 119279, I/A 23 (15.10.12).
27 de Abril de 2010Nombramientos. Auditor: J PEREPEREZ AUDITORES. Datos registrales. T 7370 , F 197, S 8, H M 119279, I/A 22 (15.04.10).
01 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacción de los artículos 10 y 11 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 7370 ,F 197, S 8, H M 119279, I/A 20 (17.02.10).
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacción del artículo 32 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 7370 , F 197, S8, H M 119279, I/A 21 (17.02.10).