Actos BORME de Ced Pericial Sa
16 de Abril de 2020Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 35132 , F 217, S 8, H M 146748, I/A 53 ( 7.04.20).
15 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: WOLFFENBUTTEL JAN-WILLEM MARTINUS. Datos registrales. T 35132 , F 217, S 8, H M146748, I/A 52m ( 8.01.20).
13 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: CURIEL RIVERA ALBERTO. Apo.Manc.: CURIEL RIVERA ALBERTO. Apoderado: CURIEL RIVERAALBERTO. Datos registrales. T 35132 , F 216, S 8, H M 146748, I/A 52 ( 6.11.19).
02 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: BLANCO RUIZ JESUS AGUSTIN. Apo.Man.Soli: ARGELAGUET VILASECA RAMON. Nombramientos.Apoderado: JIMENO GUTIERREZ JOSE MANUEL;FAUSTE DUQUE FERNANDO;CARBONELL TORRES JORDI;MORACABALLERO MIREIA;RUBIANO ALMENDRO JOSE LUIS;CURIEL RIVERA ALBERTO;AZNAR GRACIA FERNANDO;HERREROLOPEZ ALEXANDER. Datos registrales. T 35132 , F 215, S 8, H M 146748, I/A 51 (25.09.19).
08 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SCHOUWINK LOURENS. Nombramientos. Adm. Unico: WOLFFENBUTTEL JAN-WILLEMMARTINUS. Datos registrales. T 35132 , F 214, S 8, H M 146748, I/A 50 ( 1.08.19).
04 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO BARAZA ANGEL. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 48陋 LAPUBLICACION DE LA REVOCACION DEL PODER OTORGADO EN LA INSCRIPCION 43陋 COMO APODERADO MANCOMUNADOA RUBIO BARAZA ANGEL. Datos registrales. T 30719 , F 23, S 8, H M 146748, I/A 48 (12.02.19).
08 de Mayo de 2019Revocaciones. Apoderado: MARTIN EHLEN ALEXANDRA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA. Apo.Manc.: MARTIN EHLENALEXANDRA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA. Apo.Man.Soli: MARTIN EHLEN ALEXANDRA.Apo.Manc.: MARTIN EHLEN ALEXANDRA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARGELAGUET VILASECA RAMON. Apo.Manc.:FAUSTE DUQUE FERNANDO;CARBONELL TORRES JORDI;MORA CABALLERO MIREIA;RUBIANO ALMENDRO JOSELUIS;CURIEL RIVERA ALBERTO;AZNAR GRACIA FERNANDO;HERRERO LOPEZ ALEXANDER. Apo.Sol.: MONT CASTROLAURA;GARCIA GRAVI MARTA. Datos registrales. T 35132 , F 212, S 8, H M 146748, I/A 49 (29.04.19).
19 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: LUJAN CORDON MANUEL. Apo.Manc.: SANCHEZ ARROYO PEDRO PABLO. Apo.Man.Soli: RUBIOBARAZA ANGEL;RUBIO BARAZA ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIANO ALMENDRO JOSE LUIS;CURIEL RIVERAALBERTO;AZNAR GRACIA FERNANDO. Apo.Manc.: CARBONELL TORRES JORDI;MORA CABALLERO MIREIA;MARTIN EHLENALEXANDRA;HERRERO LOPEZ ALEXANDER;FAUSTE DUQUE FERNANDO. Datos registrales. T 30719 , F 23, S 8, H M 146748,I/A 48 (12.02.19).
08 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: FAUSTE DUQUE FERNANDO. Datos registrales. T 30719 , F 22, S 8, H M 146748, I/A 46 (31.01.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: BELAMAN PINTADO JULIO;BLANCO RUIZ JESUS AGUSTIN. Datos registrales. T 30719 , F 22, S 8, HM 146748, I/A 47 (31.01.19).
10 de Diciembre de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 30719 , F 22, S 8, H M 146748, I/A 45(30.11.18).
16 de Julio de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30719 , F 22, S 8, H M 146748, I/A 44 ( 6.07.18).
01 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: KRUYT PETER;ORFILA SINTES RAFAEL;COBOS ESPEJO JOSE;ORFILA SINTES RAFAEL;COBOSESPEJO JOSE. Apo.Manc.: COBOS ESPEJO JOSE;KRUYT PETER;ORFILA SINTES RAFAEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:FAUSTE DUQUE FERNANDO. Apo.Manc.: CARBONELL TORRES JORDI;RUBIO BARAZA ANGEL;MORA CABALLEROMIREIA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA;HERRERO LOPEZ ALEXANDER. Apo.Man.Soli: CARBONELL TORRES JORDI;RUBIOBARAZA ANGEL;MORA CABALLERO MIREIA. Apo.Manc.: MARTIN EHLEN ALEXANDRA;HERRERO LOPEZ ALEXANDER.Apo.Man.Soli: MARTIN EHLEN ALEXANDRA. Apo.Manc.: HERRERO LOPEZ ALEXANDER. Apo.Sol.: HERRERO LOPEZALEXANDER;MARTINEZ ARCAS ALBERTO. Datos registrales. T 30719 , F 19, S 8, H M 146748, I/A 43 (24.07.17).
29 de Febrero de 2016Revocaciones. Apoderado: RUBIO BARAZA ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIO BARAZA ANGEL. Datosregistrales. T 30719 , F 17, S 8, H M 146748, I/A 42 (19.02.16).
16 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 30719 , F 17, S 8, H M 146748, I/A 41 (9.12.15).
21 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ LOPEZ FRANCESCA. Apo.Manc.: JIMENEZ LOPEZ FRANCESCA. Nombramientos.Apoderado: RUBIO BARAZA ANGEL. Datos registrales. T 30719 , F 15, S 8, H M 146748, I/A 40 (13.10.15).
23 de Julio de 2015Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30719 , F 15, S 8, H M 146748, I/A 39 (15.07.15).
04 de Mayo de 2015Revocaciones. Apoderado: CONSUEGRA FERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 30719 , F 14, S 8, H M 146748, I/A 38(23.04.15).
06 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ ARROYO PEDRO PABLO;LOZANO LOZANO JOSE JULIO. Apo.Sol.: CALABRIA FALCONFERNANDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ GARCIA PEDRO ANTONIO;CARBONELL TORRES JORDI. Apo.Manc.:COBOS ESPEJO JOSE;MORA CABALLERO MIREIA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA;JIMENEZ LOPEZ FRANCESCA;SANCHEZARROYO PEDRO PABLO;KRUYT PETER;ORFILA SINTES RAFAEL. Datos registrales. T 30719 , F 13, S 8, H M 146748, I/A 37(26.03.15).
30 de Octubre de 2014Otros conceptos: Se sustituye el Otorgamiento segundo de la escritura que caus贸 la inscripci贸n 33& de la Hoja Social, en el sentidode rectificar el orden de los apellido del apoderado nombrado siendo el correcto: DON FERNANDO CALABRIA FALCON. Datosregistrales. T 30719 , F 12, S 8, H M 146748, I/A 36 (22.10.14).
12 de Septiembre de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. La gesti贸n, tramitaci贸n yliquidaci贸n de siniestros por cuenta de entidades aseguradoras, as铆 como la realizaci贸n por cuenta de dichas entidades de todasaquellas actividades y la prestaci贸n de todo tipo de servicios inherentes y/o relacionados con la ejecuci贸n y desarrollo de la citadaactividad de. Datos registrales. T 30719 , F 12, S 8, H M 146748, I/A 34 ( 4.09.14).
Nombramientos. Apoderado: CONSUEGRA FERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 30719 , F 12, S 8, H M 146748, I/A 35 (4.09.14).
23 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: LOZANO LOZANO JOSE JULIO;MARFANY GARCIA DEL VALLE IGNACIO. Nombramientos.Apo.Sol.: LUJAN CORDON MANUEL;FALCON CALABRIA FERNANDO. Datos registrales. T 30719 , F 11, S 8, H M 146748, I/A 33(12.06.14).
05 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VAN DER HELM WILHELMUS CORNELIS. Nombramientos. Adm. Unico: SCHOUWINKLOURENS. Datos registrales. T 30719 , F 11, S 8, H M 146748, I/A 32 (26.02.14).
30 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: GUALLAR PEREZ JOAQUIM. Nombramientos. Apoderado: ORFILA SINTES RAFAEL;COBOS ESPEJOJOSE;LOZANO LOZANO JOSE JULIO;MARTIN EHLEN ALEXANDRA. Datos registrales. T 30719 , F 10, S 8, H M 146748, I/A 31(23.09.13).
02 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: WITTEVEEN STEPHANUS W.;KRUYT PETER;VAN DER HELM WILHELMUS CORNELIS;LOZANOLOZANO JOSE JULIO;MARFANY GARCIA DEL VALLE IGNACIO;MARTIN EHLEN ALEXANDRA;MORA CABALLEROMIREIA;SANCHEZ ARROYO PEDRO PABLO. Apo.Sol.: ATIENZA CASAS SARA. Nombramientos. Apoderado: KRUYTPETER;ORFILA SINTES RAFAEL;COBOS ESPEJO JOSE;LOZANO LOZANO JOSE JULIO;MARFANY GARCIA DEL VALLEIGNACIO;MORA CABALLERO MIREIA;MARTIN EHLEN ALEXANDRA;JIMENEZ LOPEZ FRANCESCA;SANCHEZ ARROYO PEDROPABLO;MARTINEZ ARCAS ALBERTO. Datos registrales. T 30719 , F 8, S 8, H M 146748, I/A 30 (21.03.13).
21 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORFILA SINTES RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: VAN DER HELM WILHELMUSCORNELIS. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-.1. Denominaci贸n.-hasta el 21. Cambio dedomicilio social. AVDA DE MANOTERAS 6, 1& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 30719 , F 6, S 8, H M 146748, I/A 28(12.02.13).