Buscador CIF Logo

Actos BORME Celgene SL

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Celgene SL

Actos BORME Celgene SL - B84416130

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Celgene SL con CIF B84416130

🔙 Perfil de Celgene SL
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Celgene SL

08 de Septiembre de 2023
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: BMS PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL HOLDINGSNETHERL. Datos registrales. T 42435 , F 190, S 8, H M 385890, I/A 86 ( 1.09.23).

07 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: URBEZ PLASENCIA ROBERTO JAVIER. Presidente: URBEZ PLASENCIA ROBERTO JAVIER.Nombramientos. Presidente: MORALES FREDDY. Datos registrales. T 42435 , F 187, S 8, H M 385890, I/A 84 (31.08.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: URBEZ PLASENCIA ROBERTO JAVIER;URBEZ PLASENCIA ROBERTO JAVIER;PALACIOS DE LASHERAS MARIA ELENA;MORALES FREDDY. Nombramientos. Apo.Sol.: MORALES FREDDY;ORTA MORRAL SANDRA. Datosregistrales. T 42435 , F 187, S 8, H M 385890, I/A 85 (31.08.23).

26 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: O'GRADY BRIAN. Nombramientos. Apo.Sol.: ASHFORD LORNA;SOLOVYOVALEXANDER;STEWART MICHAEL DAVID;BONZLI MICHAEL HUSSEIN. Datos registrales. T 42435 , F 186, S 8, H M 385890, I/A82 (19.04.23).

13 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: CALZADA BAU MARIA DE LOS REYES. Datos registrales. T 42435 , F 185, S 8, H M 385890, I/A 81 (5.01.23).

12 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: CHAMMARTIN SUZANA. Datos registrales. T 42435 , F 185, S 8, H M 385890, I/A 80 ( 4.01.23).

17 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MEDINILLA CRISTINA;GARCIA MEDINILLA CRISTINA. Apo.Manc.: GARCIA MEDINILLACRISTINA;DE LEUSSE MARIE ALAIN GEORGES JEAN FRANCOIS. Datos registrales. T 42435 , F 185, S 8, H M 385890, I/A 79 (8.11.22).

30 de Septiembre de 2022
Fe de erratas: Se publicó por error en la inscripción 56ª la calle del nuevo domicilio social, siendo la correcta QUINTANADUEÑAS, 6de MADRID. Datos registrales. T 41466 , F 40, S 8, H M 385890, I/A 56 (12.04.21).

16 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: KELLY KATHERINE REYNOLDS. Nombramientos. Consejero: GOMEZ GALLEGO JOSEALBERTO;MORALES FREDDY. Datos registrales. T 41466 , F 44, S 8, H M 385890, I/A 66 ( 9.12.21).

07 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ GALLEGO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 41466 , F 43, S 8, H M 385890, I/A 63(31.08.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRETE OLMEDO JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 41466 , F 44, S 8, H M 385890, I/A 64(31.08.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CASAHORRAN SEBASTIAN VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 41466 , F 44, S 8, H M 385890, I/A65 (31.08.21).

06 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: RAMOS ALVES SANDRA MARIA;LLAMAZARES BLANCO DINA. Datos registrales. T 41466 , F 42, S8, H M 385890, I/A 61 (30.08.21).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ GALLEGO JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 41466 , F 42, S 8, H M 385890, I/A 62(30.08.21).

28 de Junio de 2021
Otros conceptos: Cambiado el domicilio social del Socio Unico de la Sociedad CELGENE SL, la compañía "CELGENENETHERLANDS BV" con fecha 1 de abril de 2021, a Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrech.- Datos registrales. T 41466 , F 42, S 8, HM 385890, I/A 60 (21.06.21).

04 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: DEVINOFF MICHAEL WAYNE;CABIDA MARIA JOSE. Datos registrales. T 41466 , F 41, S 8, H M385890, I/A 58 (26.04.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: DAMONTI JOHN LOUIS;COGHLAN ALICIA ANN;THAYER SNYDER SUZANNE. Datos registrales. T41466 , F 41, S 8, H M 385890, I/A 59 (26.04.21).

26 de Abril de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 41466 , F 41, S 8, H M 385890, I/A 57 (19.04.21).

19 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. C/ QUINTADUEÑAS, 6 (MADRID). Datos registrales. T 41466 , F 40, S 8, H M 385890, I/A 56(12.04.21).

18 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: URBEZ PLASENCIA ROBERTO JAVIER. Datos registrales. T 33691 , F 222, S 8, H M 385890, I/A 54(11.03.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: RAMOS SANDRA;PIGNOLET DAVID;GARCIA MEDINILLA CRISTINA;PETREMAND ANNECLAUDE;WUTHRICH OLIVIER. Apoderado: BILLER JONATHAN PRIM;PEDURTHE LAUGA PASCAL FREDERIC;MCCROSSANMAIRE AMANDA BRYN;DE LEUSSE MARIE ALAIN GEORGES JEAN FRANCOIS. Apo.Manc.: JOHANNESEN SARAH ELIZABETH.Apoderado: GARCIA MEDINILLA CRISTINA;GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: BONZLI MICHAELHUSSEIN;LLAMAZARES BLANCO DINA;SCHAFER LUC;STULTZ KATHERINE VEGA.Apo.Sol.: STULTZ KATHERINEVEGA;STULTZ KATHERINE VEGA. Nombramientos. Apo.Manc.: RAMOS ALVES SANDRA MARIA;URBEZ PLASENCIA

27 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: BILLER JONATHAN PRIM. Nombramientos. Consejero: KELLY KATHERINE REYNOLDS;URBEZPLASENCIA ROBERTO JAVIER. Datos registrales. T 33691 , F 220, S 8, H M 385890, I/A 50 (20.02.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información