Actos BORME de Celta Assistance Sl
19 de Junio de 2023Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 37 el nombramiento de GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL como apoderado,siendo lo correcto NAPAL LEONARDO JAVIER. Datos registrales. T 32940 , F 46, S 8, H M 218385, I/A 37 (23.11.21).
19 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: REY FABIANA MARCELA. Datos registrales. T 32940 , F 48, S 8, H M 218385, I/A 41 (12.12.22).
21 de Septiembre de 2022Cambio de domicilio social. C/ BUITRAGO DE LOZOYA 19 - PISO 1潞, PUERTA A. (MADRID). Datos registrales. T 32940 , F 47, S8, H M 218385, I/A 40 (14.09.22).
16 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: SOMOZA FERNANDO DANIEL;PEREZ CONDE LEANDRO AGUSTIN;NAPAL LEANDRO JAVIER.Datos registrales. T 32940 , F 47, S 8, H M 218385, I/A 39 ( 8.08.22).
20 de Mayo de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL. Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA RUIZ FERNANDOEZEQUIEL;FERNANDEZ ALFREDO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 32940 , F 46, S 8, H M 218385, I/A 38 (12.05.22).
30 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: SOMOZA FERNANDO DANIEL;FERNANDEZ ALFREDO;PEREZ CONDE LEANDROAGUSTIN;GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL. Datos registrales. T 32940 , F 46, S 8, H M 218385, I/A 37 (23.11.21).
15 de Enero de 2021Revocaciones. Apoderado: GARCIA ALONSO JUAN ALVARO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ALONSO JUAN ALVARO.Datos registrales. T 32940 , F 46, S 8, H M 218385, I/A 36 (10.01.21).
30 de Octubre de 2020Revocaciones. Apoderado: CIVILE CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 32940 , F 45, S 8, H M 218385, I/A 35 (23.10.20).
11 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: DE WAYS-RUART MAXIME-PHILIPPE D.CORNET. Datos registrales. T 32940 , F 45, S 8, H M 218385,I/A 34 ( 4.03.20).
22 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL;DE WAYS-RUART MAXIME-PHILIPPE D.CORNET.Nombramientos. Adm. Unico: GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 32940 , F 45, S 8, H M 218385, I/A 33 (15.10.19).
27 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: CIVILE OSCAR LUIS;CALVANI OSVALDO PASCUAL;GHERARDI ANDRES ERNESTO.Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA RUIZ FERNANDO;DE WAYS-RUART MAXIME-PHILIPPE D.CORNET. Datos registrales. T32940 , F 43, S 8, H M 218385, I/A 31 (19.04.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CALVANI OSVALDO -PASCUAL. Nombramientos. Adm. Solid.: GARCIA RUIZ FERNANDO;DEWAYS-RUART MAXIME-PHILIPPE D.CORNET. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 32940 , F 44, S 8, H M 218385, I/A 32 (19.04.18).
08 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: YACHELINI SANDRA LILIA. Datos registrales. T 32940 , F 43, S 8, H M 218385, I/A 30 ( 1.03.18).
07 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: REY FABIANA MARCELA. Datos registrales. T 32940 , F 42, S 8, H M 218385, I/A 27 (31.01.18).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA RUIZ FERNANDO EZEQUIEL. Datos registrales. T 32940 , F 42, S 8, H M 218385, I/A 28(31.01.18).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MENDEZ DIEGO. Datos registrales. T 32940 , F 42, S 8, H M 218385, I/A 29 (31.01.18).
04 de Diciembre de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: UNIVERSAL ASSISTANCE SA. Datos registrales. T 32940 , F 41,S 8, H M 218385, I/A 26 (24.11.17).
12 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CIVILE OSCAR LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: CALVANI OSVALDO -PASCUAL. Datosregistrales. T 32940 , F 41, S 8, H M 218385, I/A 25 ( 4.02.16).
02 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GHERARDI ANDRES ERNESTO. Datos registrales. T 32940 , F 40, S 8, H M 218385, I/A 23(23.11.15).
Nombramientos. Apoderado: YACHELINI SANDRA LILIA. Datos registrales. T 32940 , F 40, S 8, H M 218385, I/A 24 (23.11.15).
29 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: GARCIA ALONSO JUAN ALVARO. Datos registrales. T 13455 , F 79, S 8, H M 218385, I/A 22(18.12.14).
05 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: REY GOITIA DAVID MARIA. Datos registrales. T 13455 , F 79, S 8, H M 218385, I/A 21 (21.06.12).
15 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: REY GOITIA DAVID MARIA. Datos registrales. T 13455 , F 79, S 8, H M 218385, I/A 20 ( 1.12.11).
27 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: CIVILE CARLOS ALBERTO. Datos registrales. T 13455 , F 78, S 8, H M 218385, I/A 19 (16.02.09).